00151652 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresa00151652 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00151652
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de 00151652 LIMITED?

    • (5242) /

    Onde fica 00151652 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Silverworks
    67-71 Northwood Street
    B3 1TX Birmingham
    West Midlands
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de 00151652 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    AMALGAMATED COTTON MILLS TRUST LIMITED(THE)12/10/191812/10/1918

    Quais são as últimas contas de 00151652 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até29/03/2008

    Quais são as últimas submissões para 00151652 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    28 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2023

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2022

    5 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de 30 st. Pauls Square Birmingham West Midlands B3 1QZ para The Silverworks 67-71 Northwood Street Birmingham West Midlands B3 1TX em 30/03/2022

    2 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2022

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2021

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2021

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2020

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2020

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2019

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2019

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2018

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2018

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2017

    5 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O C/O Poppleton & Appleby 34-35 Ludgate Hill Birmingham B3 1EH para 30 st. Pauls Square Birmingham West Midlands B3 1QZ em 16/03/2017

    1 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2017

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2016

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2016

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2015

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2015

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2014

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2014

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/07/2013

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 12/01/2013

    5 páginas4.68

    Quem são os diretores de 00151652 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ANSELL, Terence John
    Elm Cottage
    Asheridge Road
    HP5 2XD Chesham
    Buckinghamshire
    Secretário
    Elm Cottage
    Asheridge Road
    HP5 2XD Chesham
    Buckinghamshire
    British97778790001
    HARRIS, John Graham
    17 Westfield Road
    Edgbaston
    B15 3QF Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    17 Westfield Road
    Edgbaston
    B15 3QF Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish2142680001
    WATSON, Susan Margaret
    Cressington 23 Four Oaks Road
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    Cressington 23 Four Oaks Road
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish2142690001
    ALDRIDGE, Gemma Jane Constance
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    Secretário
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    British144966000001
    BARKER, Julie Faith
    7 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    Secretário
    7 Spencer Road
    KT8 0SP East Molesey
    Surrey
    British53016860001
    BATTY, Frederick Robson
    17 Cloverdale
    Shelf
    HX3 7RP Halifax
    West Yorkshire
    Secretário
    17 Cloverdale
    Shelf
    HX3 7RP Halifax
    West Yorkshire
    British1295110002
    BOOTH, Brenda
    10 Trevor Road
    Flixton
    M41 5QH Manchester
    Secretário
    10 Trevor Road
    Flixton
    M41 5QH Manchester
    British16249170001
    BOWMAR, Raymond
    1 Metro Avenue
    DE55 5UF Newton
    Derbyshire
    Secretário
    1 Metro Avenue
    DE55 5UF Newton
    Derbyshire
    British47946970001
    JENKINS, David Huw
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    Secretário
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    British76742540002
    MCEWAN, Andrew Gilmour
    376 Wootton Road
    PE30 3EA Kings Lynn
    Norfolk
    Secretário
    376 Wootton Road
    PE30 3EA Kings Lynn
    Norfolk
    British2681910001
    O'LEARY, Simon Christopher
    64 Plimsoll Road
    N4 2EE London
    Secretário
    64 Plimsoll Road
    N4 2EE London
    British72296420001
    O'LEARY, Simon Christopher
    64 Plimsoll Road
    N4 2EE London
    Secretário
    64 Plimsoll Road
    N4 2EE London
    British72296420001
    ROSE, Belinda
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    Secretário
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    British90092080001
    STEPHENS, Julia
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    Secretário
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    British63984570001
    TABRIZI, Saeed Rismanforoosh
    127 Whitton Avenue East
    UB6 0QE Greenford
    Middlesex
    Secretário
    127 Whitton Avenue East
    UB6 0QE Greenford
    Middlesex
    British36580380001
    TABRIZI, Saeed Rismanforoosh
    127 Whitton Avenue East
    UB6 0QE Greenford
    Middlesex
    Secretário
    127 Whitton Avenue East
    UB6 0QE Greenford
    Middlesex
    British36580380001
    TAYLOR, Noel Howard
    7 Old Hartshay Hill
    DE5 3HU Ripley
    Derbyshire
    Secretário
    7 Old Hartshay Hill
    DE5 3HU Ripley
    Derbyshire
    British13254380001
    TAYLOR, Noel Howard
    7 Old Hartshay Hill
    DE5 3HU Ripley
    Derbyshire
    Secretário
    7 Old Hartshay Hill
    DE5 3HU Ripley
    Derbyshire
    British13254380001
    WATSON, Susan Margaret
    Cressington 23 Four Oaks Road
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretário
    Cressington 23 Four Oaks Road
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    British2142690001
    AKERMAN, David Lenton
    6 Chantry Close
    DE73 1ET Melbourne
    Derby
    Diretor
    6 Chantry Close
    DE73 1ET Melbourne
    Derby
    British86534370001
    BALL, John Adrian
    Watersmeet
    Mill Lane
    RG9 3LY Shiplake
    Oxfordshire
    Diretor
    Watersmeet
    Mill Lane
    RG9 3LY Shiplake
    Oxfordshire
    British11182730003
    BENNETT, Nigel William
    33 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TP London
    Diretor
    33 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TP London
    British72570780001
    BURNETT, Patricia Ann
    The Conifers
    Seabrook Road
    WD4 8NU Kings Langley
    Hertfordshire
    Diretor
    The Conifers
    Seabrook Road
    WD4 8NU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish70101270002
    CRANSTON, John Charles
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    Diretor
    8 Nottingham Road
    NG25 0LF Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish145205440001
    DUNCAN, Peter Courtney
    23 Brewers Wharf
    NG24 1ET Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    23 Brewers Wharf
    NG24 1ET Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish9496230002
    FINNIGAN, John Allan, Dr
    High Ground Moor Lane
    Long Preston
    BD23 4QQ Skipton
    North Yorkshire
    Diretor
    High Ground Moor Lane
    Long Preston
    BD23 4QQ Skipton
    North Yorkshire
    British41461960001
    HARRISON, Fiona Mary
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    Diretor
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    British40555070001
    HARRISON, Fiona Mary
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    Diretor
    Yew Tree Cottage
    North Heath
    RG20 8UD Chieveley
    Newbury
    British40555070001
    HEALY, Christopher William
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    Diretor
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    United KingdomBritish58484770001
    HOLT, David Leslie Frank
    Stonelow Flat Farm
    S42 7DE Eastmoor
    Derbyshire
    Diretor
    Stonelow Flat Farm
    S42 7DE Eastmoor
    Derbyshire
    British73659860001
    LEA, Jonathan David
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish67105270002
    MORRISON, Barry
    The Stables
    Bulls Yard Queen Street
    NG25 0AA Southwell
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Stables
    Bulls Yard Queen Street
    NG25 0AA Southwell
    Nottinghamshire
    British36461280002
    MORRISON, Barry
    The Stables
    Bulls Yard Queen Street
    NG25 0AA Southwell
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Stables
    Bulls Yard Queen Street
    NG25 0AA Southwell
    Nottinghamshire
    British36461280002
    MOULDS, Adrian Paul
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    Diretor
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish161093650001
    MOULDS, Adrian Paul
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    Diretor
    Ferris House
    Newbarn Lane
    HP9 2QZ Seer Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish161093650001

    00151652 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 10/12/2008
    Entregue em 13/12/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Waterlinks Investments Limited
    Transações
    • 13/12/2008Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 14/03/2006
    Entregue em 22/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transações
    • 22/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 23/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 13/01/2004
    Entregue em 15/01/2004
    Pendente
    Montante garantido
    £25,850.00 and retained interest thereon due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Ground floor and part basement 8/9 high street marlborough.
    Pessoas com direito
    • O & H Limited
    Transações
    • 15/01/2004Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 23/09/2003
    Entregue em 02/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transações
    • 02/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 17/02/2003
    Entregue em 25/02/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Amphitrite Limited
    Transações
    • 25/02/2003Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trust deed
    Criado em 28/05/1971
    Entregue em 04/06/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £12,323,906 debenture stock of carrying to viyella LTD
    Breve descrição
    Floating charge undertaking and all property and present and future including umcalled capital.
    Pessoas com direito
    • Commercial Union Assurance Company LTD
    Transações
    • 04/06/1971Registro de uma garantia
    • 25/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    00151652 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    07/01/2009Início da administração
    13/01/2010Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Martin T Coyne
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham
    Profissional
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham
    Andrew Turpin
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham
    Profissional
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham
    2
    DataTipo
    22/10/2023Data prevista de dissolução
    13/01/2010Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Andrew Turpin
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham
    Profissional
    Poppleton & Appleby
    35 Ludgate Hill
    B3 1EH Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0