L.R.RUSSELL LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | L.R.RUSSELL LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00156981 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de L.R.RUSSELL LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica L.R.RUSSELL LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de L.R.RUSSELL LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 27/12/2015 |
Quais são as últimas submissões para L.R.RUSSELL LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Justin Matthew King como diretor em 31/10/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/12/2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Segunda apresentação para a cessação de funções de Nils Olin Steinmeyer como administrador | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Segunda apresentação para a cessação de funções de Kevin Michael Bradshaw como administrador | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Justin Matthew King como diretor em 18/08/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen Thomas Murphy como diretor em 18/08/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 22/07/2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/04/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Thomas Murphy como diretor em 06/04/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Roger Mclaughlan como diretor em 10/03/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Nils Olin Steinmeyer como diretor em 06/04/2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Anthony Gerald Jones como diretor em 06/04/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kevin Michael Bradshaw como diretor em 10/03/2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF para Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF em 23/02/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/12/2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/04/2015 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF para Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF em 22/05/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 29/12/2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/04/2014 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/12/2012 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/04/2013 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Kevin Michael Bradshaw como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de L.R.RUSSELL LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Anthony Gerald | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Cfo | 212265950001 | ||||
MCLAUGHLAN, Roger | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Ceo | 206428840001 | ||||
FORREST, David Mervyn | Secretário | Clouds Farm Drayton TA10 0JT Langport Somerset | British | 50457500001 | ||||||
JONES, Anthony David | Secretário | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | Chartered Accountant | 73622510001 | |||||
MURFIN, Stephen | Secretário | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Company Director | 8690590001 | |||||
PEARCE, Patrick John | Secretário | Blue Cedars Bunces Lane Burghfield Common RG7 3DL Reading Berkshire | British | 28975060001 | ||||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Secretário | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | Finance Director | 76162020001 | |||||
SPENCER SMITH, Thomas Peter | Secretário | The Old Rectory Llanvetherine NP7 8RG Abergavenny Gwent | British | 1470160001 | ||||||
BRADSHAW, Kevin Michael | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Company Director | 124019940001 | ||||
BRIGDEN, Peter | Diretor | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director Of Retail Operation | 195802400001 | ||||
CAUNCE, John Geoffrey | Diretor | 16 Beaconsfield Road Claygate KT10 0PW Esher Surrey | British | Company Director | 1470170001 | |||||
FAVELL, Gary Alan | Diretor | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | Chief Executive | 107699240001 | ||||
FORREST, David Mervyn | Diretor | Clouds Farm Drayton TA10 0JT Langport Somerset | British | Company Director | 50457500001 | |||||
HEWITT, Robert John | Diretor | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15486070002 | ||||
HODKINSON, James Clifford | Diretor | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | Company Director | 606430001 | ||||
JENKINSON, Antonia Scarlett | Diretor | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | Investment Banker | 72128340003 | ||||
KING, Justin Matthew | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 213157990001 | ||||
KOZLOWSKI, Richard Leon | Diretor | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 124967710001 | ||||
LIVINGSTON, William Andrew | Diretor | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | Commercial Director | 111439220001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Diretor | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Diretor | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MURFIN, Stephen | Diretor | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Company Director | 8690590001 | |||||
MURPHY, Stephen Thomas | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Chairman | 207509410001 | ||||
PRICE, Glyn John | Diretor | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 73470720001 | ||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Diretor | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | Finance Director | 76162020001 | ||||
SPENCER SMITH, Thomas Peter | Diretor | The Old Rectory Llanvetherine NP7 8RG Abergavenny Gwent | British | Company Director | 1470160001 | |||||
STEINMEYER, Nils Olin | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | Financial Director | 126422100002 | ||||
STEVENSON, Barry John | Diretor | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | Company Director | 102595670001 | ||||
VAUGHAN, David John | Diretor | Bryn Cain Penpergwm NP7 9AE Abergavenny Gwent | United Kingdom | British | Solicitor | 44521810001 |
L.R.RUSSELL LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Criado em 24/02/2009 Entregue em 04/03/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 13/01/1995 Entregue em 26/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 13/01/1995 Entregue em 25/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 13/01/1995 Entregue em 25/01/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 08/12/1992 Entregue em 23/12/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Composite guarantee and mortgage debenture | Criado em 08/12/1992 Entregue em 23/12/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge | |
Breve descrição Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 23/03/1988 Entregue em 05/04/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 23/03/1988 Entregue em 05/04/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 29/09/1982 Entregue em 11/10/1982 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 12/03/1980 Entregue em 26/03/1980 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 27/11/1972 Entregue em 14/12/1972 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Inst of charge | Criado em 16/02/1959 Entregue em 04/03/1959 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due etc. | |
Breve descrição Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Series of debentures | Criado em 16/04/1936 Entregue em 16/04/1936 | Totalmente satisfeita | ||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0