L.R.RUSSELL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaL.R.RUSSELL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00156981
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de L.R.RUSSELL LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica L.R.RUSSELL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de L.R.RUSSELL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/12/2015

    Quais são as últimas submissões para L.R.RUSSELL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Justin Matthew King como diretor em 31/10/2016

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/12/2015

    8 páginasAA

    Segunda apresentação para a cessação de funções de Nils Olin Steinmeyer como administrador

    4 páginasRP04TM01

    Segunda apresentação para a cessação de funções de Kevin Michael Bradshaw como administrador

    4 páginasRP04TM01

    Nomeação de Mr Justin Matthew King como diretor em 18/08/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen Thomas Murphy como diretor em 18/08/2016

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 22/07/2016

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 28/04/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/05/2016

    Estado do capital em 18/05/2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomeação de Mr Stephen Thomas Murphy como diretor em 06/04/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Roger Mclaughlan como diretor em 10/03/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nils Olin Steinmeyer como diretor em 06/04/2016

    2 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    22/09/2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Nomeação de Mr Anthony Gerald Jones como diretor em 06/04/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kevin Michael Bradshaw como diretor em 10/03/2016

    2 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    22/09/2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016.

    Endereço do domicílio registado alterado de Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF para Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF em 23/02/2016

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/12/2014

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/04/2015 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/05/2015

    Estado do capital em 22/05/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF para Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF em 22/05/2015

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 29/12/2013

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/04/2014 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/05/2014

    Estado do capital em 19/05/2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/12/2012

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 28/04/2013 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Nomeação de Mr Kevin Michael Bradshaw como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de L.R.RUSSELL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Secretário
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    British50457500001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Secretário
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Secretário
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    Secretário
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    British28975060001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Secretário
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Secretário
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    British1470160001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Diretor
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    CAUNCE, John Geoffrey
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    Diretor
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director1470170001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Diretor
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Diretor
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    BritishCompany Director50457500001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Diretor
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Diretor
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Diretor
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Diretor
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Diretor
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Diretor
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Diretor
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Diretor
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    BritishCompany Director1470160001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Diretor
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    VAUGHAN, David John
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    Diretor
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishSolicitor44521810001

    L.R.RUSSELL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 24/02/2009
    Entregue em 04/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transações
    • 04/03/2009Registro de uma garantia (395)
    • 04/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal mortgage
    Criado em 13/01/1995
    Entregue em 26/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 26/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/01/1995
    Entregue em 25/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 25/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/01/1995
    Entregue em 25/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 25/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 08/12/1992
    Entregue em 23/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transações
    • 23/12/1992Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Criado em 08/12/1992
    Entregue em 23/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge
    Breve descrição
    Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/12/1992Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 23/03/1988
    Entregue em 05/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business.
    Pessoas com direito
    • Hill Samuel & Co Limited.
    Transações
    • 05/04/1988Registro de uma garantia
    • 30/11/1991Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Legal mortgage
    Criado em 23/03/1988
    Entregue em 05/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business.
    Pessoas com direito
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transações
    • 05/04/1988Registro de uma garantia
    • 30/11/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 29/09/1982
    Entregue em 11/10/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/10/1982Registro de uma garantia
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/03/1980
    Entregue em 26/03/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/03/1980Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 27/11/1972
    Entregue em 14/12/1972
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/12/1972Registro de uma garantia
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Inst of charge
    Criado em 16/02/1959
    Entregue em 04/03/1959
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc.
    Breve descrição
    Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate.
    Pessoas com direito
    • Westminster Bank LTD
    Transações
    • 04/03/1959Registro de uma garantia
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 16/04/1936
    Entregue em 16/04/1936
    Totalmente satisfeita
    Transações
    • 16/04/1936Registro de uma garantia
    • 12/04/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0