SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSELECTA REFRESHMENTS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00157122
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Finway Road Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SELECTA UK LIMITED20/01/200320/01/2003
    VENDEPAC LIMITED01/05/199801/05/1998
    TM GROUP LIMITED12/05/198612/05/1986
    MAYFAIR GROUP LIMITED31/12/198131/12/1981
    STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED16/07/191916/07/1919

    Quais são as últimas contas de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2022

    Quais são as últimas submissões para SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England para 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT em 15/11/2022

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021

    12 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Anthony Michael Leon como diretor em 01/04/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Paul Nathaniel Ian Hearne como diretor em 01/04/2021

    2 páginasAP01

    Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/12/2019

    16 páginasAA

    legacy

    68 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Nomeação de Mr Anthony Michael Leon como diretor em 20/10/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Marta Schwartz como diretor em 20/10/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/03/2020 com atualizações

    3 páginasCS01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/09/2019 para 31/12/2019

    1 páginasAA01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2018

    25 páginasAA

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Nomeação de Marta Schwartz como diretor em 01/09/2019

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr.
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish124527170003
    VRIJLANDT, Jan Marck
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch201873380001
    BAKER, Roger Owen
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    Secretário
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    British18801330003
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Secretário
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretário
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MERCER, Roderick
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    Secretário
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    British129465490001
    MILLER, Simon Jonathan
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    Secretário
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    British88269280001
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    Secretário
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    British147336500001
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Secretário
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Diretor
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritish183822370001
    BATE, David Martin
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    Diretor
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    British130717000002
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Diretor
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    Diretor
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritish451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    Diretor
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    British36622820001
    BURROWS, Helen
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    Diretor
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish171865220001
    COWING, Helen
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    Diretor
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    NetherlandsBritish156849560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Diretor
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    CULLENS, Alan
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Diretor
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    British6875310001
    HUGHES, Geraint
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Diretor
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    SwitzerlandBritish169470320001
    JONES, Dylan Glynn
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Diretor
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish153523810001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    British56997350002
    LANCASTER, James
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Diretor
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    EnglandBritish147052660001
    LEON, Anthony Michael
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Diretor
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    EnglandBritish242255050001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Diretor
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish12314170002
    MAUGUY, Philippe Francis Robert
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Diretor
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish, French179402830001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Diretor
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    MEE, Andy Edward
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    Diretor
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    EnglandBritish177086470001
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    Diretor
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    British6907290001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Diretor
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Diretor
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish124498400001
    PORTER, Andrew Graham
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish64331540001
    SCHWAB, Martin
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    Diretor
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss123132130001
    SCHWARTZ, Marta
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Diretor
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    United KingdomPolish262359470001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    19/12/2017
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00209116
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    Kkr & Co.L.P
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    06/04/2016
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    Sim
    Forma jurídicaLimited Partnership
    País de registroDelaware
    Autoridade legalDelaware
    Local de registroRegistered In Delaware
    Número de registroState File No. 4378294
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 27/02/2017
    Entregue em 01/03/2017
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Factofrance
    Transações
    • 01/03/2017Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 20/06/2014
    Entregue em 26/06/2014
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transações
    • 26/06/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 07/02/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 13/01/2012
    Entregue em 27/01/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wgtc Nominees Limited
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    Transações
    • 27/01/2012Registro de uma garantia (MG01)
    Fixed and floating secuirty document
    Criado em 28/09/2007
    Entregue em 10/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank Pls as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 10/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Charge over deposit
    Criado em 08/12/2000
    Entregue em 19/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents
    Breve descrição
    1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 28/11/1998
    Entregue em 08/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 26/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over deposit account
    Criado em 10/07/1998
    Entregue em 27/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined)
    Breve descrição
    The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC; As Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 27/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed
    Criado em 10/07/1998
    Entregue em 27/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland P.L.C.; As Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transações
    • 27/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed
    Criado em 17/04/1998
    Entregue em 23/04/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995
    Breve descrição
    Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC(Security Trustee)
    Transações
    • 23/04/1998Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Criado em 06/12/1996
    Entregue em 09/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995
    Breve descrição
    L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Share pledge
    Criado em 24/07/1995
    Entregue em 02/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 02/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 26/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Share pledge
    Criado em 24/07/1995
    Entregue em 02/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 02/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 26/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 24/07/1995
    Entregue em 31/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Breve descrição
    L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 31/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 01/04/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0