SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00215000 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SCOTTISH & NEWCASTLE HOTELS LIMITED | 19/08/1994 | 19/08/1994 |
| TAMPLIN'S LICENSED PROPERTIES LIMITED | 12/07/1926 | 12/07/1926 |
Quais são as últimas contas de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 22/08/2015 |
Quais são as últimas submissões para SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 11/01/2018 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL para Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU em 13/09/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 02/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom para Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL em 08/02/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Lindsay Anne Keswick como secretário em 25/04/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Claire Susan Stewart como secretário em 25/04/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ para Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT em 07/03/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2016 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 22/08/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Jonathan Robert Langford como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Daryl Antony Kelly como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Lucy Jane Bell como diretor em 26/01/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Kirk Dyson Davis como diretor em 21/12/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Henry Jones como secretário em 04/12/2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercício contabilístico atual encurtado de 24/08/2016 para 30/04/2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Término da nomeação de Patrick James Gallagher como diretor em 23/06/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2015 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 23/08/2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/03/2014 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 17/08/2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secretário | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523600001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Secretário | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secretário | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretário | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretário | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592260001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secretário | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445620001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretário | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretário | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021780001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretário | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretário | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Diretor | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Diretor | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Diretor | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Diretor | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Diretor | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Diretor | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Diretor | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Diretor | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Diretor | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Diretor | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Diretor | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Diretor | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Diretor | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Notificado em | Cessado em | Declaração |
|---|---|---|
| 02/03/2017 | A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Criado em 15/12/2003 Entregue em 31/12/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge | Criado em 05/01/1989 Entregue em 12/01/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Criado em 30/09/1985 Entregue em 07/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Sterling pounds 1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of sterling pounds 349,595 5% redeemable debenture stock 2000, sterling pounds 243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & sterling pounds 696,193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all moneys intended to be secured by a trust deed dated 7/2/62 & deeds supplemental thereto. | |
Breve descrição First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 24/05/1983 Entregue em 25/05/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing sterling pounds 50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC & for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of the trust deed dated 7/2/62 and supplemental thereto | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 28/07/1970 Entregue em 12/08/1970 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 53,127,463 inclusive of sterling pounds 45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 31/07/1967 Entregue em 31/07/1967 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 45,627,463 inclusive of sterling pounds 35,627,463 secured by trust deed dated 7/2/62 and deeds suppl. Thereto | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Equitable charge without instrument | Criado em 08/05/1967 Entregue em 26/05/1967 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 10,000,000 | |
Breve descrição First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 26/07/1965 Entregue em 28/07/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 7,500,000 | |
Breve descrição Floating charge on the (see doc. 82). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 26/03/1965 Entregue em 06/04/1965 | Totalmente satisfeita | Montante garantido 1,347,268 debenture stock of watney mann LTD. | |
Breve descrição Floating charge:. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 22/01/1964 Entregue em 23/06/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 8,000,000 | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. (See doc 77). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed | Criado em 08/02/1962 Entregue em 08/02/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For further securing sterling pounds 5,000,000 debenture stock of watney mann limited, (see doc 73 for further details) | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Trust deed. | Criado em 07/02/1962 Entregue em 07/02/1962 | Totalmente satisfeita | Montante garantido For further securing sterling pounds 13,780,195 debenture stock of watney mann LTD. (For further details see doc 72) | |
Breve descrição Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0