CMPI HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCMPI HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00239142
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    UTRAVEL.CO.UK LIMITED12/07/200012/07/2000
    UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED28/06/200028/06/2000
    MILLER FREEMAN UK LIMITED08/04/199808/04/1998
    MILLER FREEMAN PLC01/06/199501/06/1995
    MORGAN - GRAMPIAN P L C30/04/192930/04/1929

    Quais são as últimas contas de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    2 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 com atualizações

    5 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Carl Sheldon Adrian em 07/12/2018

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Crosswall Nominees Limited em 04/12/2018

    1 páginasCH02

    Endereço do domicílio registado alterado de 240 Blackfriars Road London SE1 8BF para 5 Howick Place London SW1P 1WG em 06/12/2018

    1 páginasAD01

    Detalhes do secretário alterados para Crosswall Nominees Limited em 04/12/2018

    1 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Unm Investments Limited em 04/12/2018

    1 páginasCH02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    18 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    18 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2016 com atualizações

    6 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    18 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/12/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/01/2016

    Estado do capital em 08/01/2016

    • Capital: GBP .995
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    14 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/04/2015 com lista completa de acionistas

    15 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/08/2015

    Estado do capital em 18/08/2015

    • Capital: GBP .995459
    SH01

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Detalhes do diretor alterados para Crosswall Nominees Limited em 16/02/2015

    1 páginasCH02

    Detalhes do diretor alterados para Carl Adrian em 16/02/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Unm Investments Limited em 16/02/2015

    1 páginasCH02

    Detalhes do secretário alterados para Crosswall Nominees Limited em 16/02/2015

    1 páginasCH04

    Endereço do domicílio registado alterado de Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY para 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF em 17/04/2015

    1 páginasAD01

    Quem são os diretores de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Secretário
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro950209
    992770004
    ADRIAN, Carl Sheldon
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Diretor
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish134006860001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Diretor
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro950209
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Diretor
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro1219152
    48157320003
    PURSER, Jean Dorothy Anne
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    Secretário
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    British94669070001
    SECKER, James
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    Secretário
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    British1219420001
    SIMPSON, Mark Andrew Goodman
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    Secretário
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    British56280120001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Secretário
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    ARNOLD, Anthony Burton
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    Diretor
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish8572820001
    ARNOLD, Stanley Richard
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    Diretor
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    British34857830001
    BAKER, David Arthur
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    British6265440001
    BRAZIER, John Ansell
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    Diretor
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    EnglandBritish53359450001
    CAMPBELL, James Milne
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    Diretor
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    British49487790001
    CONLON, Denis
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    Diretor
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    British8471710001
    CUNNINGHAM, Paul
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    Diretor
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    British17122880004
    DE CARLE, John Brian
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    Diretor
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    British8317060001
    DOWNING, Brian George Kirby
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    British8426380001
    ELLINGS, Clive Bryan
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66808150001
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    FERGUSON, Ailsa Murray
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    Diretor
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    British69565050001
    FOSTER, Maurice Curtis
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    British8173280001
    FREEMAN, Marshall William
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    Diretor
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    American11882820001
    GRAY, Bernard Peter
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    Diretor
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    British108397670001
    JAKES, Clifford Duncan
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    Diretor
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    British8426370001
    KING, Harold Leslie
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    Diretor
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    British14996700001
    LEVY, Rupert James
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    Diretor
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    British57681630002
    LLOYD, Julian Stuart
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    Diretor
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    British59624160002
    LOMAX, Diana
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    Diretor
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    British49719540003
    MCALEENAN, Patrick David
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    Diretor
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    EnglandBritish14226510001
    MELVILLE, Iain Boyd
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    Diretor
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    British34669410002
    MICHAEL, Roger Lucas
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    Diretor
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish99335210001
    NAUGHTON, Shane Paul
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Diretor
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Irish124972750001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Diretor
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Diretor
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    30/06/2016
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    Não
    Forma jurídicaUnlimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro152298
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    CMPI HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Mortgage
    Criado em 06/02/1984
    Entregue em 16/02/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983.
    Breve descrição
    All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 16/02/1984Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 31/10/1983
    Entregue em 30/11/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge
    Breve descrição
    Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 30/11/1983Registro de uma garantia
    Facility letter
    Criado em 26/10/1983
    Entregue em 03/11/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83
    Breve descrição
    Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209).
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 03/11/1983Registro de uma garantia
    Omnibus letter of set-off
    Criado em 30/06/1982
    Entregue em 08/07/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 08/07/1982Registro de uma garantia
    Omnibus letter of set-off
    Criado em 26/02/1982
    Entregue em 05/03/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descrição
    All sums standing to the credit of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 05/03/1982Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 10/08/1978
    Entregue em 10/08/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982
    Breve descrição
    All book debts and other debts present and future.
    Pessoas com direito
    • European American Banking Corporation
    Transações
    • 10/08/1982Registro de uma garantia
    Legal mortgage
    Criado em 02/08/1971
    Entregue em 03/08/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Co.
    Transações
    • 03/08/1971Registro de uma garantia
    • 27/08/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/06/1969
    Entregue em 07/07/1969
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details).
    Pessoas com direito
    • Coutts & Co.
    Transações
    • 07/07/1969Registro de uma garantia
    • 27/08/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0