CMPI HOLDINGS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CMPI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00239142 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CMPI HOLDINGS LIMITED?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 5 Howick Place SW1P 1WG London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| UTRAVEL.CO.UK LIMITED | 12/07/2000 | 12/07/2000 |
| UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED | 28/06/2000 | 28/06/2000 |
| MILLER FREEMAN UK LIMITED | 08/04/1998 | 08/04/1998 |
| MILLER FREEMAN PLC | 01/06/1995 | 01/06/1995 |
| MORGAN - GRAMPIAN P L C | 30/04/1929 | 30/04/1929 |
Quais são as últimas contas de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Carl Sheldon Adrian em 07/12/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Crosswall Nominees Limited em 04/12/2018 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 240 Blackfriars Road London SE1 8BF para 5 Howick Place London SW1P 1WG em 06/12/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Crosswall Nominees Limited em 04/12/2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Unm Investments Limited em 04/12/2018 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2016 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 31/12/2015 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 10/04/2015 com lista completa de acionistas | 15 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Crosswall Nominees Limited em 16/02/2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Carl Adrian em 16/02/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Unm Investments Limited em 16/02/2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Crosswall Nominees Limited em 16/02/2015 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY para 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF em 17/04/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Quem são os diretores de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Secretário | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| ADRIAN, Carl Sheldon | Diretor | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 134006860001 | |||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Diretor | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| UNM INVESTMENTS LIMITED | Diretor | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 48157320003 | ||||||||||
| PURSER, Jean Dorothy Anne | Secretário | The Dumbles 7 Ashdown View TN22 3HX Nutley East Sussex | British | 94669070001 | ||||||||||
| SECKER, James | Secretário | Berwyn 1 Links Close TN6 1QW Crowborough East Sussex | British | 1219420001 | ||||||||||
| SIMPSON, Mark Andrew Goodman | Secretário | Crockford House Snow Hill Crawley Down RH10 3EE Crawley West Sussex | British | 56280120001 | ||||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Secretário | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||||||
| ARNOLD, Anthony Burton | Diretor | Oldbury Farm Southend Road Great Wakering SS3 0PJ Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 8572820001 | |||||||||
| ARNOLD, Stanley Richard | Diretor | Great Bubhurst Farm Bubhurst Lane Frittenden TN17 2BD Cranbrook Kent | British | 34857830001 | ||||||||||
| BAKER, David Arthur | Diretor | Oakwood Shoreham Road Otford TN14 5RN Sevenoaks Kent | British | 6265440001 | ||||||||||
| BRAZIER, John Ansell | Diretor | Little Croft 22 Norbury Way KT23 4RY Great Bookham Surrey | England | British | 53359450001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Milne | Diretor | 22 Lower Hill Road KT19 8LT Epsom Surrey | British | 49487790001 | ||||||||||
| CONLON, Denis | Diretor | Woodstock Westmore Road Tatsfield TN16 2BJ Westerham Kent | British | 8471710001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Paul | Diretor | 110 Chestnut Grove SW12 8JJ London | British | 17122880004 | ||||||||||
| DE CARLE, John Brian | Diretor | Folly Hill Cottage Friezley Lane TN17 2LL Cranbrook Kent | British | 8317060001 | ||||||||||
| DOWNING, Brian George Kirby | Diretor | 35 Badingham Drive Fetcham KT22 9EU Leatherhead Surrey | British | 8426380001 | ||||||||||
| ELLINGS, Clive Bryan | Diretor | Priors Lea The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66808150001 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Diretor | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Diretor | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| FERGUSON, Ailsa Murray | Diretor | 18 Hosack Road SW17 7QP London | British | 69565050001 | ||||||||||
| FOSTER, Maurice Curtis | Diretor | White House Farm Ivy Hatch TN15 0NN Sevenoaks Kent | British | 8173280001 | ||||||||||
| FREEMAN, Marshall William | Diretor | PO BOX 645 94528 Diablo California Usa | American | 11882820001 | ||||||||||
| GRAY, Bernard Peter | Diretor | Apartment 35 Blk B 3rd Floor 10 Wild Street WC2B 4RL London | British | 108397670001 | ||||||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Diretor | Littlehay Burley BH24 4AG Ringwood Hampshire | British | 8426370001 | ||||||||||
| KING, Harold Leslie | Diretor | 17 Wildcroft Manor Wildcroft Road SW15 3TS London | British | 14996700001 | ||||||||||
| LEVY, Rupert James | Diretor | 25 Muswell Avenue N10 2EB London | British | 57681630002 | ||||||||||
| LLOYD, Julian Stuart | Diretor | 6 Queens Gate Villas Victoria Park Road E9 7BU London | British | 59624160002 | ||||||||||
| LOMAX, Diana | Diretor | 17 Parsons Green Lane SW6 4HL London | British | 49719540003 | ||||||||||
| MCALEENAN, Patrick David | Diretor | Hazlewell Road Putney SW15 6UR London 78 | England | British | 14226510001 | |||||||||
| MELVILLE, Iain Boyd | Diretor | 34 Waterlow Road RH2 7EX Reigate Surrey | British | 34669410002 | ||||||||||
| MICHAEL, Roger Lucas | Diretor | 22 Greenways WD5 0EU Abbots Langley Hertfordshire | United Kingdom | British | 99335210001 | |||||||||
| NAUGHTON, Shane Paul | Diretor | 41 Neville House 19 Page Street, Westminster SW1P 4JX London | Irish | 124972750001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Diretor | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Diretor | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubmg Holdings | 30/06/2016 | Blackfriars Road SE1 8BF London 240 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CMPI HOLDINGS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Criado em 06/02/1984 Entregue em 16/02/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983. | |
Breve descrição All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge | Criado em 31/10/1983 Entregue em 30/11/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge | |
Breve descrição Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Facility letter | Criado em 26/10/1983 Entregue em 03/11/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83 | |
Breve descrição Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Criado em 30/06/1982 Entregue em 08/07/1982 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição All sums standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Criado em 26/02/1982 Entregue em 05/03/1982 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Breve descrição All sums standing to the credit of the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge | Criado em 10/08/1978 Entregue em 10/08/1982 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982 | |
Breve descrição All book debts and other debts present and future. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 02/08/1971 Entregue em 03/08/1971 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 27/06/1969 Entregue em 07/07/1969 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0