WILSON CONNOLLY LIMITED

WILSON CONNOLLY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWILSON CONNOLLY LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00244804
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WILCON HOMES LIMITED31/12/197731/12/1977
    WILCON CONSTRUCTION LIMITED02/01/193002/01/1930

    Quais são as últimas contas de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2024
    Próximas contas vencem em30/09/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até03/04/2025
    Próxima declaração de confirmação vence17/04/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até03/04/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Michael Andrew Lonnon como secretário em 09/12/2024

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Sayed Suleiman Ashrafi como secretário em 09/12/2024

    2 páginasAP03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023

    11 páginasAA

    Término da nomeação de Omolola Olutomilayo Adedoyin como diretor em 24/04/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Jennifer Canty como diretor em 24/04/2024

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 03/04/2024 com atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como diretor em 09/10/2023

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Katherine Elizabeth Hindmarsh como diretor em 09/10/2023

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022

    12 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 03/04/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021

    13 páginasAA

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 55

    2 páginasMR05

    Declaração de confirmação apresentada em 03/04/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    15 páginasAA

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom para Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD02

    Declaração de confirmação apresentada em 03/04/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2019

    19 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 03/04/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Colin Richard Clapham como diretor em 31/10/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como diretor em 31/10/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Ian Graham Connor como diretor em 25/10/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Sarah Judith Thornley como diretor em 25/10/2019

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    20 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 20/04/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347940001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    CONNOR, Ian Graham
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193626080001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secretário
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretário
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Secretário
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    Secretário
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BANNISTER, William Henry
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Diretor
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector58990140003
    BEAL, Ian Paul
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    Diretor
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    BritishDirector71260780003
    BELL, Darren
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Diretor
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    United KingdomBritishManaging Director73256080001
    BENSON, Deborah Clare
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    Diretor
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    BritishManaging Director52845300004
    BLACK, Ian Craig
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    Diretor
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant4579780003
    BROOMFIELD, Matthew
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector80131820001
    BURGESS, Alan Robert
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    Diretor
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director79587600001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CHANDRAN, Vikranth
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    Diretor
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant139652640001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    COKER, John Edwin
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director100513680001
    DICKERSON, Graham Leslie
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    Diretor
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    EnglandBritishManaging Director127266390001
    EDGINGTON, Richard Alan
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    Diretor
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    EnglandBritishManaging Director81884240001
    FAULKNER, Jeffrey Dean
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    Diretor
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector77563410003
    FLOOD, Robert William
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    Diretor
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    EnglandBritishManaging Director134877050001
    FOULKES, Christopher Andrew
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    Diretor
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    United KingdomBritishNone33941280001
    FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director48396030001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Diretor
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    GREENING, Malcolm David
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    Diretor
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director58648450001
    GRIFFITHS, Melvyn Robert
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    Diretor
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector113395580001
    HATCH, Christopher John
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50577850006
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    HOLLAND-KAYE, William John
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    Diretor
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    BritishManaging Director110518040001
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    KENRICK, Joanne Louise
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    Diretor
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    BritishDirector75636150002

    Quem são as pessoas com controle significativo de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro832629
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    WILSON CONNOLLY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 03/07/2009
    Entregue em 16/07/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each guarantor or borrower or chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. 34 turnpike road, red lodge, freckenahm part t/no SK80912. Insurances and other contracts see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited (the Security Agent) as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transações
    • 16/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 01/07/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 01/07/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 04/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 27/10/2003
    Entregue em 30/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £3,308,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    The freehold land situated at upton rocks widnes chesire.
    Pessoas com direito
    • The Council of the Borough of Halton
    Transações
    • 30/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 11/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 24/10/2003
    Entregue em 30/10/2003
    Pendente
    Montante garantido
    £2,450,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The freehold land and premises known as part of nunnery fields hospital nunnery fields canterbury kent.
    Pessoas com direito
    • East Kent Hospitals National Health Service Trust
    Transações
    • 30/10/2003Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 21/10/2003
    Entregue em 28/10/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The whole of the l/h land being 146 orrell road, orrell t/no GM607707.
    Pessoas com direito
    • Steven John Burness and Rita Ann Burness
    Transações
    • 28/10/2003Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 30/09/2003
    Entregue em 11/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land at wychwood village, crewe, cheshire,.
    Pessoas com direito
    • Countryside Properties PLC
    Transações
    • 11/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/08/2003
    Entregue em 13/08/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All that f/h property situate and k/a coryton house 27 pendwyallt road coryton cardiff.
    Pessoas com direito
    • Royal Mail Group PLC
    Transações
    • 13/08/2003Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 07/07/2003
    Entregue em 09/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £5,908,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    All that f/h property situate at manor farm crescent off brook way bradley stoke south glos containing approx 7.6 acres.
    Pessoas com direito
    • South Gloucestershire District Council
    Transações
    • 09/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 23/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 20/06/2003
    Entregue em 24/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The freehold land known as and forming part of woodlands memorial ground blackpool road ansdell lytham st annes.
    Pessoas com direito
    • Fylde Rugby Union Football Club Limited
    Transações
    • 24/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 02/05/2003
    Entregue em 03/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £3,429,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land on the east side of southend road hornchurch essex.
    Pessoas com direito
    • Maylands Green Estate Co Limited & Romford Construction Company Limited
    Transações
    • 03/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 28/04/2003
    Entregue em 10/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land comprising old stowupland park stowmarket suffolk.
    Pessoas com direito
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transações
    • 10/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 28/04/2003
    Entregue em 03/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land comprising old stowupland park, stowmarket, suffolk.
    Pessoas com direito
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transações
    • 03/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 25/04/2003
    Entregue em 29/04/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Scholes park farm and scholes lodge farm scholes leeds west yorkshire.
    Pessoas com direito
    • Scholes Park Developments Limited
    Transações
    • 29/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 27/07/2022Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    Legal charge
    Criado em 23/04/2003
    Entregue em 01/05/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The sum of £2,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H property k/a the woodlands park hotel wellington road timperley cheshire t/no: GM171621.
    Pessoas com direito
    • Brian Norris Walker
    Transações
    • 01/05/2003Registro de uma garantia (395)
    • 27/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 01/04/2003
    Entregue em 16/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All that freehold property under t/n's CH423380 and CH423391 and the rights interest and estate in the land described in the statutory declarations of david stone and derek nuttall dated 25 march 2003. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Northwich Victoria Football Club Company Limited
    Transações
    • 16/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 01/04/2003
    Entregue em 16/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the northwich victoria football club company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All that freehold property known as or being the football stadium and land at the drill field northwich cheshire. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 04/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 26/03/2003
    Entregue em 09/04/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the land at medway trading estate hart street maidstone kent t/no K583305.
    Pessoas com direito
    • Bernard Christopher Norman Roger Holmes
    Transações
    • 09/04/2003Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 26/03/2003
    Entregue em 29/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    One million six hundred thousand pounds (£1,600,000) due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land on the south east side of hart street, maidstone, kent t/n K583305.
    Pessoas com direito
    • Cathedral Medway Limited
    Transações
    • 29/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 11/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 20/12/2002
    Entregue em 06/01/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £21,660,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land at orsett hospital rowley road basildon essex.
    Pessoas com direito
    • Basildon and Thurrock General Hospitals National Health Service Trust
    Transações
    • 06/01/2003Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 04/10/2002
    Entregue em 08/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £750,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Land to the rear of tidings hill halstead essex.
    Pessoas com direito
    • G E Cook & Sons Limited
    Transações
    • 08/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 11/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/08/2002
    Entregue em 31/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The property k/a land to the south of clay lane, fishbourne, nr chichester, west sussex t/no. WSX257370.
    Pessoas com direito
    • Seaward Homes (South) Limited
    Transações
    • 31/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 28/06/2002
    Entregue em 18/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land at county way, trowbridge, wiltshire.
    Pessoas com direito
    • Swan Hill Developments Limited
    Transações
    • 18/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 26/03/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 16/05/2002
    Entregue em 22/05/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land at lee mill,ivybridge,devon.
    Pessoas com direito
    • Peter Joseph Cane and William John Cane
    Transações
    • 22/05/2002Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 18/04/2002
    Entregue em 02/05/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H land lying to the south of codicote road, wheathampstead, hertfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Sainsbury's Supermarkets Limited
    Transações
    • 02/05/2002Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 21/03/2002
    Entregue em 26/03/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Land and buildings on the north east side of carver street, birmingham, forming part of the land t/n WM467585.
    Pessoas com direito
    • Midland and City Limited, Baystone Associates Limited, and Lampol Developments Limited Togethertrading as Ppk Partnership
    Transações
    • 26/03/2002Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 21/12/2001
    Entregue em 04/01/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All that freehold land lying to the south of codicote road wheathampstead hertfordshire.
    Pessoas com direito
    • Sainsburys Supermarkets Limited
    Transações
    • 04/01/2002Registro de uma garantia (395)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0