CAPB LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAPB LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00262511
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAPB LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica CAPB LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    GRIFFINS
    Tavistock House South Tavistock Square
    WC1H 9LG London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAPB LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CA PREMIER BANKING LIMITED23/07/200123/07/2001
    ROBERT FLEMING & CO.LIMITED06/02/193206/02/1932

    Quais são as últimas contas de CAPB LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Qual é o status da última declaração anual para CAPB LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para CAPB LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    15 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2015

    14 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2014

    10 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de * 2 Triton Square Regent's Place London NW1 3AN* em 20/06/2013

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed ca premier banking LIMITED\certificate issued on 15/05/13
    2 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name15/05/2013

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Estado do capital em 14/05/2013

    • Capital: GBP 1
    7 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 31/03/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Santander Secretariat Services Limited como secretário

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Abbey National Nominees Limited como secretário

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    6 páginasAA

    Nomeação de Derek John Lewis como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jessica Petrie como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 31/03/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Jessica Frances Petrie como diretor

    3 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Shaun Patrick Coles em 10/11/2011

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Scott Linsley como diretor

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para David Martin Green em 31/05/2011

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de CAPB LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Secretário
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro3072288
    171739990001
    COLES, Shaun Patrick
    Triton Square
    Regents Place
    NW1 3AN London
    2
    Diretor
    Triton Square
    Regents Place
    NW1 3AN London
    2
    United KingdomBritish95706540002
    GREEN, David Martin
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    Diretor
    Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish157202700001
    LEWIS, Derek John
    B01)
    Santander Uk Plc 2 Triton Square, Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretariat (Ts6
    United Kingdom
    Diretor
    B01)
    Santander Uk Plc 2 Triton Square, Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretariat (Ts6
    United Kingdom
    EnglandBritish34423910002
    LIONE, Christine Amelia
    52 Addison Road
    E11 2RG London
    Secretário
    52 Addison Road
    E11 2RG London
    British65685130001
    STONE, Celia Eileen Susan
    170a Moor Lane
    Cranham
    RM14 1HE Upminster
    Essex
    Secretário
    170a Moor Lane
    Cranham
    RM14 1HE Upminster
    Essex
    British34397540002
    ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    Secretário
    2 Triton Square
    Regent's Place
    NW1 3AN London
    Abbey National House
    133895950001
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secretário
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    ROBERT FLEMMING CORPORATE SERVICES LIMITED
    10 Aldermanbury
    EC2V 7RF London
    Secretário
    10 Aldermanbury
    EC2V 7RF London
    75422360001
    ARCHIBALD, John Gordon
    Greenways
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    Diretor
    Greenways
    Totteridge Green
    N20 8PA London
    EnglandBritish86989460001
    ARMSTRONG, Andrew Charles
    9 Royal Bay Apartments
    La Rue Horman, Grouville
    JE3 9EJ Jersey
    Channel Islands
    Diretor
    9 Royal Bay Apartments
    La Rue Horman, Grouville
    JE3 9EJ Jersey
    Channel Islands
    British77620750001
    ASHTON, Charles James
    Park Road
    CM8 3PS Rivenhall
    Rivenhall Place
    Essex
    Diretor
    Park Road
    CM8 3PS Rivenhall
    Rivenhall Place
    Essex
    United KingdomBritish139012420002
    BAINES, Michael George Coriat Talbot
    Pound Cottage
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    Diretor
    Pound Cottage
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish75994140001
    BALL, Simon Peter
    Glendalough 19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    Diretor
    Glendalough 19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    British78766980001
    BANKS, William Lawrence
    Ridgebourne
    HR5 3EG Kington
    Herefordshire
    Diretor
    Ridgebourne
    HR5 3EG Kington
    Herefordshire
    United KingdomBritish36083600002
    BARTON, Malcolm Peter Speight
    Sydenhams
    GL6 7BU Bisley
    Gloucestershire
    Diretor
    Sydenhams
    GL6 7BU Bisley
    Gloucestershire
    United KingdomBritish45376130004
    BRADLEY, Philip Herbert Gilbert
    30 Smith Terrace
    SW3 4DH London
    Diretor
    30 Smith Terrace
    SW3 4DH London
    EnglandIrish30045470002
    BREAME, John Alan
    42 Ruskin Drive
    BR6 9RR Orpington
    Kent
    Diretor
    42 Ruskin Drive
    BR6 9RR Orpington
    Kent
    British30045480001
    BRIANT, Julian Gerard Hugh
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Diretor
    Little Tylers 26 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    British58558290001
    BROWN, Adam David
    25 Parkside
    AL6 9DQ Welwyn
    Hertfordshire
    Diretor
    25 Parkside
    AL6 9DQ Welwyn
    Hertfordshire
    British52863320001
    BRUCE, James Henry Morys
    1 St. Peters Square
    W1 9AB London
    Diretor
    1 St. Peters Square
    W1 9AB London
    British94088510001
    BRYAN, Jonathan Paul
    36 First Avenue
    HP7 9BL Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    36 First Avenue
    HP7 9BL Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglish38599520001
    BURKE, Andrew Lindsay
    25 Kilmaine Road
    SW6 7JU London
    Diretor
    25 Kilmaine Road
    SW6 7JU London
    United KingdomIrish43083790001
    BUTT, Nicholas Alec Geoffrey
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    Diretor
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    British30045500001
    BUTT, Nicholas Alec Geoffrey
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    Diretor
    40 Queens Gate Mews
    SW7 5QN London
    British30045500001
    CHAMBERS, Antony Craven
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    Diretor
    The Lake House
    SO24 9DB Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish94516690001
    CHWEIDAN, Russell
    Kilbrachen 6 Meadway Close
    NW11 7BA London
    Diretor
    Kilbrachen 6 Meadway Close
    NW11 7BA London
    British47267810002
    COALES, William Oliver Alexander
    32 Stockwell Park Road
    SW9 0AJ London
    Diretor
    32 Stockwell Park Road
    SW9 0AJ London
    EnglandBritish41286830001
    COLE, Jonathan Mark
    38 Norroy Road
    Putney
    SW15 1PF London
    Diretor
    38 Norroy Road
    Putney
    SW15 1PF London
    British47267770001
    CONNOR, Janet
    Cavanaghs Cottage
    18 Bedford Road
    NN7 1DR Denton
    Northamptonshire
    Diretor
    Cavanaghs Cottage
    18 Bedford Road
    NN7 1DR Denton
    Northamptonshire
    British77312440001
    CONSTABLE, Peter John
    38 Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    38 Harcourt Terrace
    SP2 7SA Salisbury
    Wiltshire
    British4562100001
    COOPER, Robert Hamilton
    5 Farrington Place
    BR7 6BE Chislehurst
    Kent
    Diretor
    5 Farrington Place
    BR7 6BE Chislehurst
    Kent
    British11632250001
    COTTRELL, Christopher
    Tickners Ravenscroft Farm Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HW Edenbridge
    Kent
    Diretor
    Tickners Ravenscroft Farm Spode Lane
    Cowden
    TN8 7HW Edenbridge
    Kent
    British53152470001
    CRAIG, Colin James
    3 Kersley Street
    Battersea
    SW11 4PR London
    Diretor
    3 Kersley Street
    Battersea
    SW11 4PR London
    British7793240001
    DAVIS, Roger William John
    Maytree House
    161 Clarence Road
    SL4 5AP Windsor
    Berkshire
    Diretor
    Maytree House
    161 Clarence Road
    SL4 5AP Windsor
    Berkshire
    British77101740001

    CAPB LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security deed
    Criado em 22/06/2000
    Entregue em 05/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of security
    Criado em 03/12/1999
    Entregue em 23/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a participation agreement of even date or this charge
    Breve descrição
    All the benefit of the company's right title and interest in the following: a loan agreement dated 3/12/99, a debenture dated 20/5/97, a rental income account assignment dated 3/12/99 and others as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 23/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 23/03/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security deed
    Criado em 23/09/1999
    Entregue em 01/10/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All debts obligations and liabilities due or to become due from the company and/or the nominee to the chargee on any account whatsoever out of or in connection with the facility agreement ; the security deed or any assured payment by the bank (all as defined in the deed)
    Breve descrição
    All sums and payments now and from time to time hereafter receivable by the nominee or for the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 01/10/1999Registro de uma garantia (395)
    • 26/05/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Declaration of pledge of securities and claims
    Criado em 22/12/1997
    Entregue em 29/12/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Breve descrição
    (I) all present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as all other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxemborg law ("securities");. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Banque Bruxelles Lambert S.A.
    • Banque Generale Du Luxemborg S.A.
    • Citibank N.A.
    • Union Bank of Switzerlandthe Composition of the Syndicate May Periodically Change and the Term Guarantor Refers to the Syndicate of Banks from Time to Time
    • The Guarantormeaning a Syndicate of Banks Whose Lead Bank Iscitibank N.A. Brussels Branch, and Whose Members Include:
    • Kredietbank N.V.
    • Banque Internationale a Luxemborg S.A
    • Credit Commercial De France
    • Kredietbank S.A. Luxemburgeoise
    Transações
    • 29/12/1997Registro de uma garantia (395)
    • 11/05/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed
    Criado em 11/05/1990
    Entregue em 24/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Breve descrição
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by the chargee in the account (s) in the name of the company in the books of the chargee denominated "adr pre-release collateral account(s)" together with the debts arising there from or in respect thereof.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 24/05/1990Registro de uma garantia
    • 04/05/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 11/05/1990
    Entregue em 24/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the security agreement
    Breve descrição
    All adrs which are at the date of the security agreement or might at any time thereafter be in or which might at any time thereafter be delivered into, the possession of the chargee or that of its agents, representatives or correspondents & held for the account of the company (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 24/05/1990Registro de uma garantia
    • 19/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collaleral agreement
    Criado em 21/02/1989
    Entregue em 27/02/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All collateral:- being all of the borrowers right title at interest in and to all securities clearance accounts (see form 395 for further details).
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 27/02/1989Registro de uma garantia
    • 11/05/2001Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 25/07/1988
    Entregue em 26/07/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transações
    • 26/07/1988Registro de uma garantia
    • 28/04/2000Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CAPB LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    31/05/2013Início da liquidação
    27/08/2016Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Kevin Ashley Goldfarb
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    Profissional
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0