GEEST SHIPPING LIMITED

GEEST SHIPPING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGEEST SHIPPING LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00266840
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GEEST SHIPPING LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica GEEST SHIPPING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Eaglepoint Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GEEST SHIPPING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GEEST LINE LIMITED17/12/200817/12/2008
    GEEST BANANAS LIMITED07/10/199607/10/1996
    GEEST INDUSTRIES LIMITED01/09/198801/09/1988
    STASSEN,LIMITED08/07/193208/07/1932

    Quais são as últimas contas de GEEST SHIPPING LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2024
    Próximas contas vencem em30/09/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/12/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para GEEST SHIPPING LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até19/05/2025
    Próxima declaração de confirmação vence02/06/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até19/05/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para GEEST SHIPPING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Robert Waterman como diretor em 03/12/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Alan Buckland como diretor em 03/12/2024

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Peter Bernard Dixon como diretor em 10/05/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Robert Waterman como diretor em 10/05/2024

    2 páginasAP01

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/12/2023

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/12/2022

    6 páginasAA

    Contas de micro-entidade preparadas até 01/01/2022

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 02/01/2021

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas de isenção total preparadas até 28/12/2019

    6 páginasAA

    Nomeação de Mr Christopher John Roberts como secretário em 20/05/2020

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Cecil Frank Ryan como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Renwick Elsworth Adrian Rose como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jeronimo Poggio Voormolen como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Thomas Gerard Murphy como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Vincent Mccann como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Ezechiel Joseph como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Bernard Cornibert como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Bernard Cornibert como secretário em 20/05/2020

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Coen Bos como diretor em 20/05/2020

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Captain Peter Bernard Dixon em 20/05/2020

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mr Christopher John Roberts como diretor em 20/05/2020

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de GEEST SHIPPING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ROBERTS, Christopher John
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Secretário
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    270005070001
    BUCKLAND, Alan
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    WalesBritishDirector267590990001
    ROBERTS, Christopher John
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant58553340001
    CORNIBERT, Bernard
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Secretário
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    BritishEconomist39026980002
    GERNON, John Francis
    The Square
    Blackrock
    IRISH Dundalk
    Co Louth
    Ireland
    Secretário
    The Square
    Blackrock
    IRISH Dundalk
    Co Louth
    Ireland
    Irish46015760001
    JEFFARES, Arthur Steele
    31 Lamont Road
    SW10 0HS London
    Secretário
    31 Lamont Road
    SW10 0HS London
    British2873920001
    SCRIVEN, Jane Katherine
    Manor Farm Manor Road
    Sutton
    PE5 7XG Wansford
    Cambridgeshire
    Secretário
    Manor Farm Manor Road
    Sutton
    PE5 7XG Wansford
    Cambridgeshire
    British3536930008
    WALLACE, Brian Godman
    The Old Barn
    28 Main Street
    LE15 7PL Market Overton
    Leicestershire
    Secretário
    The Old Barn
    28 Main Street
    LE15 7PL Market Overton
    Leicestershire
    British34264790001
    BOS, Coen
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    NetherlandsDutchCompany Director112663360001
    CORNIBERT, Bernard
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    EnglandBritishEconomist39026980002
    DANIEL, Montgomery
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    St VincentVincentianCivil Servant112367810001
    DETERVILLE, Hilford David Alexander
    99 Chayssee Road
    Castries
    FOREIGN Saint Lucia
    West Indies
    Diretor
    99 Chayssee Road
    Castries
    FOREIGN Saint Lucia
    West Indies
    Saint LucianAttorney At Law62804610001
    DIXON, Peter Bernard, Captain
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director168175760001
    ELLIS, Arthur John
    38 Forest View
    Chingford
    E4 7AU London
    Diretor
    38 Forest View
    Chingford
    E4 7AU London
    EnglandBritishDirector6806190001
    EUSTACE, Arnhim Ulric
    Ratho Mill P O Box 76
    Kingstown
    St Vincent & Grenadines
    Diretor
    Ratho Mill P O Box 76
    Kingstown
    St Vincent & Grenadines
    VincentianFiscal Adviser47218420001
    FLETCHER, James Louis, Dr
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Saint LuciaSaint LucianCivil Servant167956220001
    FLETCHER, James Louis, Dr
    Cap Estate
    PO BOX 291
    FOREIGN Castries
    St Lucia
    Diretor
    Cap Estate
    PO BOX 291
    FOREIGN Castries
    St Lucia
    St LucianCivil Servant91495680001
    GREENE, Simeon
    Diamond Village
    Diamond Po
    St Vincent
    St Vincent & The Grenadines
    Diretor
    Diamond Village
    Diamond Po
    St Vincent
    St Vincent & The Grenadines
    VincentianPermanent Secretary76779920001
    JEFFARES, Arthur Steele
    31 Lamont Road
    SW10 0HS London
    Diretor
    31 Lamont Road
    SW10 0HS London
    BritishRetired2873920001
    JNO CHARLES, Vanoulst
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    DominicaDominicanRetired70176230001
    JOSEPH, Ezechiel
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Saint LuciaSt LucianGovernment Minister230818550001
    JOSIE, Peter
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    St LuciaSt LucianAgronomist120792890001
    MCCANN, Carl Patrick Mccann
    12c Clyde Lane
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Diretor
    12c Clyde Lane
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrishDirector8294790001
    MCCANN, David Vincent
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    IrelandIrishDirector39270440001
    MCGRATH, Douglas Alexander
    Paddock House
    2 Main Street
    LE15 7QA Cold Overton Oakham
    Leicestershire
    Diretor
    Paddock House
    2 Main Street
    LE15 7QA Cold Overton Oakham
    Leicestershire
    BritishCompany Director56064200001
    MURPHY, Thomas Gerard
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    IrelandIrishFinance Director52508830002
    POGGIO VOORMOLEN, Jeronimo
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    England
    NetherlandsDutchManager155865270001
    PULLEN, Jonathan Mark
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    1 Beechgrove Gardens
    Henley Road
    SL7 2TH Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director38923660001
    READE-JAHN, Ronald James
    Birch Barn
    Birch Vale
    LE15 7PL Stockport
    Diretor
    Birch Barn
    Birch Vale
    LE15 7PL Stockport
    British10402220001
    ROSE, Renwick Elsworth Adrian
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Saint Vincent And The GrenadinesVincentianRetired268799200001
    RYAN, Cecil Frank
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Saint Vincent And The GrenadinesVincentianBusiness Consultant230891600001
    SCRIVEN, Jane Katherine
    Manor Farm Manor Road
    Sutton
    PE5 7XG Wansford
    Cambridgeshire
    Diretor
    Manor Farm Manor Road
    Sutton
    PE5 7XG Wansford
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Secretary3536930008
    SPIRLING, John William
    88 North Promenade
    FY8 2QP Lytham St Annes
    Lancashire
    Diretor
    88 North Promenade
    FY8 2QP Lytham St Annes
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director208166960001
    STIELL, Simon Emmanuel Kervin
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    Diretor
    Little Park Farm Road
    Segensworth
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    Hampshire
    GrenadaGrenadianPolitician212244440001
    STOTT, Robert Winston
    Hall Croft
    5 Hall Drive
    LS16 9JF Bramhope Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Hall Croft
    5 Hall Drive
    LS16 9JF Bramhope Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director96668950001

    Quem são as pessoas com controle significativo de GEEST SHIPPING LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Geest Line Limited
    Little Park Farm Road
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    England
    01/01/2017
    Little Park Farm Road
    PO15 5TD Fareham
    Eaglepoint
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEngland
    Local de registroEngland
    Número de registro03421133
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GEEST SHIPPING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Standard security presented for registration in scotland on 13TH june 1996
    Criado em 31/05/1996
    Entregue em 22/06/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture dated 1ST may 1996
    Breve descrição
    The company's interest as tenants in the leases (as defined in form 395) of all and whole the land buildings and others on the south east side of horsley brae wishaw comprising t/no's:- LAN26534, LAN65711, LAN70868, LAN72687 & LAN114297. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks PLC
    Transações
    • 22/06/1996Registro de uma garantia (395)
    • 28/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 31/05/1996
    Entregue em 11/06/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility any swap agreement and/or these presentes (all as defined in the composite guarantee and debenture)
    Breve descrição
    Various properties as defined in schedule 3 of the debenture. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks PLC
    Transações
    • 11/06/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 25TH january 1996
    Criado em 23/01/1996
    Entregue em 07/02/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a composite guarantee and debenture dated 9TH january 1996
    Breve descrição
    Land and buildings at garion bridge wishaw. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks PLC
    Transações
    • 07/02/1996Registro de uma garantia (395)
    • 20/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 09/01/1996
    Entregue em 26/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "facility" any interest swap agreement and/or these presents (all as defined in the composite guarantee and debenture)
    Breve descrição
    Various properties (7) as defined in form 395 relative to the composite guarantee and debenture. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks PLC
    Transações
    • 26/01/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Statuory mortgage
    Criado em 08/10/1990
    Entregue em 26/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of two financing agreements both dated 24/9/80 and a deed of covenant of even date.
    Breve descrição
    64/64TH shares of and in M.V. "geestbay" reg'd in the name of the company at the port of boston under official no. 389026.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 26/10/1990Registro de uma garantia
    • 01/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Statutory mortgage
    Criado em 08/10/1990
    Entregue em 17/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of the financial agreements (as defined in the charge) and the deed of covenant dated 8/10/9/.
    Breve descrição
    64/64TH shares of and in M.V. "geestport" reg'd in the name of the company at the port of boston official no. 398206.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 17/10/1990Registro de uma garantia
    • 01/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of covenant
    Criado em 08/10/1990
    Entregue em 17/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the security documents or any of them (as defined in the charge)
    Breve descrição
    All the company's right, title, interest and benefit in and under M.V. "geestport" reg'd at port of boston, official no. 398206 and the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of the vessel. (See doc M15).
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 17/10/1990Registro de uma garantia
    • 01/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of covenant
    Criado em 08/10/1990
    Entregue em 17/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the terms of the security documents or any of them (as defined in the charge)
    Breve descrição
    All the company's right, title and interest and benefit in and under M.V. "geestbay" reg'd at port of boston official no. 389026 and the earnings and insurances of the vessel and any compensation payable in respect of the vessel. (See doc M18).
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 17/10/1990Registro de uma garantia
    • 01/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0