CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00267455 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 8 Canada Square E14 5HQ London United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
PEUREULA INVESTMENTS LIMITED | 03/08/1932 | 03/08/1932 |
Quais são as últimas contas de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2011 |
Quais são as últimas submissões para CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Término da nomeação de Hollie Rheanna Wood como secretário em 24/07/2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nomeação de Katherine Dean como secretário em 24/07/2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado do capital em 17/06/2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Término da nomeação de Karen Lyon como secretário em 04/04/2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nomeação de Hollie Rheanna Wood como secretário em 04/04/2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 12/01/2013 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2011 | 24 páginas | AA | ||||||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado | 2 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Richard John Cole como diretor em 31/05/2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Andrew David John Moffat como diretor em 31/05/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 2 Jubilee Place London SW3 3TQ em 11/06/2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 12/01/2012 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nomeação de Jonathan Peter Marlow como diretor em 30/11/2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Laurence Edwin Hayes como diretor em 30/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Karen Lyon em 02/08/2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Edward Glover como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2010 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Término da nomeação de Sarah Gledhill como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Sharon Kerridge como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEAN, Katherine | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180088270001 | |||||||
COLE, Richard John | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 32663530001 | ||||
MARLOW, Jonathan Peter | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 159417990001 | ||||
BANDEL, Martin Howard | Secretário | Gable End 29 Christchurch Crescent WD7 8AQ Radlett Hertfordshire | British | 37249220002 | ||||||
BLACK, Nicola Suzanne | Secretário | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
COLE, Jennifer | Secretário | Flat 2 The Earl Of Devon 213 Devons Road Bow Common E3 3QX London | British | 74489480002 | ||||||
FORSTER, Helen | Secretário | Flat 4 5 Corkran Road KT6 6PL Surbiton Surrey | British | 106129360001 | ||||||
JENKINSON, Louisa Jane | Secretário | 12 Amberley Close Send GU23 7BX Woking Surrey | British | 106060330002 | ||||||
LYON, Karen | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | Other | 140536930001 | ||||||
MILLER, Philip | Secretário | 87 Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London | British | 121053850001 | ||||||
NIVEN, Frances Julie | Secretário | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | Company Secretary | 78670270001 | |||||
POOLE, Rebecca Louise | Secretário | 69b Replingham Road Southfields SW18 5LU Wimbledon | British | 92013940001 | ||||||
STUART-SMITH, Gordon | Secretário | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | 5463920001 | ||||||
WOOD, Hollie Rheanna | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 177184380001 | |||||||
PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED | Secretário | 55 Basinghall Street EC2V 5HD London | 76827740001 | |||||||
ALLPORT, Howard Coplestone | Diretor | 20 Fernshaw Road SW10 0TE London | British | Company Director | 3356770001 | |||||
ASHKEN, Karol Maksymilian | Diretor | 60 Chapel Road KT20 5SE Tadworth Surrey | British | Retired Banker | 6684100002 | |||||
BANDEL, Martin Howard | Diretor | Gable End 29 Christchurch Crescent WD7 8AQ Radlett Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 37249220002 | ||||
DE ALBUQUERQUE, Simon Peter | Diretor | 15 Fielding Mews Barnes SW13 9EY London | England | British | Banker | 150525130001 | ||||
EDWARDS, Dylan Crocker | Diretor | 22 Greenway Gardens UB6 9TT Greenford Middlesex | British | Chartered Surveyor | 5965630001 | |||||
GLEDHILL, Sarah Louise | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | Accountant | 131963100002 | ||||
GLOVER, Edward Douglas | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Merchant Banker | 121380002 | ||||
HAYES, Laurence Edwin | Diretor | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | United Kingdom | British | Accountant | 192784770001 | ||||
HOLBROOK, Carolyn | Diretor | 5 Croftside CO8 5LL Bures St Mary Suffolk | United Kingdom | British | Property Management | 165098780001 | ||||
KERRIDGE, Sharon Diana Mandy | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 128267610003 | ||||
MOFFAT, Andrew David John | Diretor | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | England | British | Merchant Banker | 34399870003 | ||||
RAWLINS, Richard Denis | Diretor | 183 Ramsden Road SW12 8RG London | United Kingdom | British | Surveyor | 56889050001 | ||||
STUART-SMITH, Gordon | Diretor | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | Chartered Accountant | 5463920001 | |||||
SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian | Diretor | Flat 3 18 Camden Hill Gardens W8 7AY London | United Kingdom | British | Company Director | 76573230001 | ||||
THORP, Timothy Geoffrey | Diretor | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | Chartered Accountant | 66923730003 | ||||
VON GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich | Diretor | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | England | German, | Banker | 110089200001 |
CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 16/07/1996 Entregue em 31/07/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Composite debenture | Criado em 27/09/1990 Entregue em 05/10/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of even date | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 30/03/1983 Entregue em 07/04/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land at 1 branksea street and works adjoining fulham fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deposit of deeds without instrument. | Criado em 22/12/1977 Entregue em 05/01/1978 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 30, somerville road, small heath, birmingham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Sub-charge | Criado em 23/11/1977 Entregue em 09/12/1977 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The debt of £7,221,009.42 that the co. Shall not be at liberty to create any mortgage or charge (see doc M115). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 27/04/1977 Entregue em 10/05/1977 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 74, davey rd, handswoth birmingham 20. together with all fixtures etc. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 27/04/1977 Entregue em 10/05/1977 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 108 & 126 alvechurch road west heath, birmingham 31 together with all fixtures etc. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 08/12/1976 Entregue em 09/12/1976 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All those properties briefly described in the schedule (attached to doc 111) tog. With all fixtures whatsoever.(see doc.111 For further details) . | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 20/09/1974 Entregue em 04/10/1974 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A floating charge on the (see doc 101 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0