THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD
Visão geral
Nome da empresa | THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00328043 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Endereço do escritório registrado | 350 Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading Berkshire United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
AVIMO LIMITED | 22/05/1937 | 22/05/1937 |
Quais são as últimas contas de THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/05/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Michael William Peter Seabrook em 08/05/2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Michael William Peter Seabrook em 02/08/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael William Peter Seabrook como diretor em 22/03/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ewen Angus Mccrorie como diretor em 22/03/2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 2 Dashwood Lang Road the Bourne Business Park Addlestone Nr Weybridge Surrey KT15 2NX para 350 Longwater Avenue Green Park Reading Berkshire RG2 6GF em 09/05/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stuart Michael Boulton como diretor em 22/03/2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Guy Maurice Edmond Blanguernon como diretor em 22/03/2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/05/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Marion Elizabeth Broughton como diretor em 01/01/2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Stuart Michael Boulton como diretor em 01/01/2016 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/05/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/05/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 04/12/2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
Quem são os diretores de THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEABROOK, Michael William Peter | Secretário | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | British | 70900110002 | ||||||
MCCRORIE, Ewen Angus | Diretor | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | Scotland | British | Finance Director | 93611530001 | ||||
SEABROOK, Michael William Peter | Diretor | Longwater Avenue Green Park RG2 6GF Reading 350 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 70900110004 | ||||
BISHOP, Brian Charles | Secretário | 12 Burgess Close TA1 4NU Taunton Somerset | British | 9447760001 | ||||||
FRANCIS, Gary | Secretário | 74 Hamilton Road TA1 2ES Taunton Somerset | British | Director | 37548320001 | |||||
BLANGUERNON, Guy Maurice Edmond | Diretor | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Nr Weybridge Surrey | United Kingdom | French | Company Director | 181776570001 | ||||
BOOTH, Ian Clark | Diretor | 9 Ardmore Park 25-01 Pangkor Block FOREIGN Singapore 1025 | British | Managing Director | 42633690002 | |||||
BOULTON, Stuart Michael | Diretor | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Nr Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 87926400002 | ||||
BROUGHTON, Marion Elizabeth | Diretor | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Nr Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 94639940001 | ||||
BROWN, William Edward | Diretor | 14 Rectory Drive Weston Under Lizard TF11 8QQ Shifnal Shropshire | British | Operations Director | 82964830001 | |||||
CLARKE, Richard John George | Diretor | Redwood Harp Hill Charlton Kings GL52 6PX Cheltenham Gloucestershire | England | British | Finance Director | 38606270001 | ||||
CRESSWELL, Alexander Colin Kynaston | Diretor | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Nr Weybridge Surrey | England | British | Professional Engineer | 219909610002 | ||||
FIELDING, Colin, Sir | Diretor | 3 Rosemount Drive Bickley BR1 2LQ Bromley Kent | English | Company Director | 25646820001 | |||||
FRANCIS, Gary | Diretor | 74 Hamilton Road TA1 2ES Taunton Somerset | England | British | Managing Director | 37548320001 | ||||
GANE, Christopher Nigel | Diretor | 6 Troon Drive PA11 3HF Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | Director | 73268030001 | ||||
HANDS, Richard | Diretor | 48 Gander Hill RH16 1RD Haywards Heath West Sussex | British | Company Director | 48973280001 | |||||
HARTNELL, Roy | Diretor | Wistaria Rectory Road Staplegrove TA2 6EL Taunton Somerset | British | Commercial & Sales | 37541670001 | |||||
HILLIER, Stuart Brydon | Diretor | Manor Farm Pitney TA10 9AQ Langport Somerset | British | Marketing Director | 9683790002 | |||||
HILLIER, Stuart Brydon | Diretor | Manor Farm Pitney TA10 9AQ Langport Somerset | British | Company Director | 9683790002 | |||||
HOPE, Frank Robert | Diretor | Iona Ham Creech St Michael TA3 5NZ Taunton Somerset | British | Managing Director | 62308870001 | |||||
IVIMEY COOK, Richard Charles | Diretor | 10 The Chestnuts OX14 3YN Abingdon Oxfordshire | England | British | Accountant | 74353360002 | ||||
LUA, Sootheng | Diretor | 442a Dunearn Road FOREIGN Singapore 1128 | Singaporean | Finance Director | 39358660001 | |||||
MCCRORIE, Ewen Angus | Diretor | 2 Dashwood Lang Road The Bourne Business Park KT15 2NX Addlestone Nr Weybridge Surrey | Scotland | British | Finance Director | 93611530001 | ||||
MEADOWS, William Rowland | Diretor | Green Leas Pilgrims Wayt TN15 7NN Wrotham Kent | British | Managing Director | 40254290002 | |||||
MEADOWS, William Rowland | Diretor | Green Leas Pilgrims Wayt TN15 7NN Wrotham Kent | British | Managing Director | 40254290002 | |||||
PREST, Nicholas Martin | Diretor | 85 Elgin Crescent W11 2JF London | Great Britain | British | Company Director (Chairman) | 36518090001 | ||||
RUNKEE, Neil | Diretor | 23 Ellen Gardens Chandlers Ford SO53 4RG Eastleigh Hampshire | British | Company Director | 47533360001 | |||||
SEATON, Peter | Diretor | Teviotdale Stoke St Mary TA3 5SU Taunton Somerset | British | Company Director | 9447770002 | |||||
TURNER, Stephen Reginald | Diretor | Brynllithrig Barn Rhuallt LL17 0TP St Asaph Denbighshire | British | Managing Director | 78458970001 | |||||
VENABLES, Keith | Diretor | 16 Eight Acre Lane TA21 8PS Wellington Somerset | British | Technical Director | 50273120001 | |||||
WHITE, Brian Noble | Diretor | Westwinds Hoo Lane GL55 6AZ Chipping Campden Gloucestershire | British | Director | 9435520001 | |||||
WILSON, Alexander David, Dr | Diretor | 97 Woodside Terrace Lane Park G3 7XP Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 103792570001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thales Optronics Limited | 06/04/2016 | Linthouse Road Govan G51 4BZ Glasgow 1 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
THALES OPTRONICS (TAUNTON) LTD possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Deed of accession and supplemental charge | Criado em 30/09/1991 Entregue em 15/10/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this deed | |
Breve descrição (See doc M395-M808C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture. | Criado em 25/06/1990 Entregue em 11/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Trade marks mortgage | Criado em 25/06/1990 Entregue em 11/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All trade marks and applications for trade marks as defined on form M395, ref M133. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Patents charge | Criado em 25/06/1990 Entregue em 11/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All inventions and patents, as defined on form M395, ref M123. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Designs charge | Criado em 25/06/1990 Entregue em 11/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All designs as defined on form M395, ref M133. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage of copyright. | Criado em 25/06/1990 Entregue em 11/07/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All copyrights, design rights and rights defined on form M395, ref M103. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture. | Criado em 09/09/1971 Entregue em 30/09/1971 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company or all or any of the seven other companies named in doc 113. to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. By way of fixed & floating charge. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 14/11/1968 Entregue em 21/11/1968 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Mort. For securing £85,000 & all other monies due or to become due from the co to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descrição Freehold premises in cyril st, taunton somerset & policies of assurance. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0