SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED

SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00364651
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    • fabricação de sabões e detergentes (20411) / Indústrias transformadoras

    Onde fica SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Denby Hall Way
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Derbyshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DEB LIMITED01/12/199201/12/1992
    DEB GROUP LIMITED01/09/198601/09/1986
    DEB LIMITED22/03/198322/03/1983
    DEB CHEMICAL PROPRIETARIES LIMITED02/01/194102/01/1941

    Quais são as últimas contas de SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em30/06/2024
    Próximas contas vencem em31/03/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até22/05/2025
    Próxima declaração de confirmação vence05/06/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até22/05/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Nomeação de Mr Antonio Tomaso Brambilla Di Civesio como diretor em 11/11/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Lynval Mellor como diretor em 11/11/2024

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Benjamin Roth como diretor em 01/08/2024

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Gina Marie Burnett como diretor em 01/08/2024

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2023

    34 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 01/07/2022

    34 páginasAA

    Contas anuais preparadas até 02/07/2021

    34 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 03/07/2020

    34 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Lynval Mellor como diretor em 23/02/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas Noel Hardwick Matterson como diretor em 23/02/2021

    1 páginasTM01

    Nomeação de Ms Gina Marie Burnett como diretor em 10/12/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nadia Patricia Estrada como diretor em 10/12/2020

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 28/06/2019

    26 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 29/06/2018

    23 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Nomeação de Ms Nadia Patricia Estrada como diretor em 31/08/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jeffrey Bell como diretor em 31/08/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 22/05/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BRAMBILLA DI CIVESIO, Antonio Tomaso
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    SwitzerlandItalianVice President Europe329237770001
    ROTH, Benjamin
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director326602280001
    BAKER, Russell Edward James
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Secretário
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    British73520630001
    BLACKWELL, John David
    40 Mill Street
    IM9 1AG Castletown
    Isle Of Man
    Secretário
    40 Mill Street
    IM9 1AG Castletown
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant44920140007
    NEILSON, Paul Gregory Tyler
    The Old Vicarage Baldhoon Road
    IM4 7NG Laxey
    Isle Of Man
    Secretário
    The Old Vicarage Baldhoon Road
    IM4 7NG Laxey
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant57979710004
    TILLEARD, Roy William
    Avistine
    Glen Road
    IM9 4HW Colby
    Isle Of Man
    Secretário
    Avistine
    Glen Road
    IM9 4HW Colby
    Isle Of Man
    BritishAccountant10047220006
    WILLIAMSON, Andrew
    Linacre Queens Drive
    DE56 2TJ Belper
    Derbyshire
    Secretário
    Linacre Queens Drive
    DE56 2TJ Belper
    Derbyshire
    British26237590001
    ANDERSON, Bryan George Frank
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive178436950001
    BAKER, Russell Edward James
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director73520630001
    BELL, Jeffrey
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director104047700001
    BLACKWELL, John David
    40 Mill Street
    IM9 1AG Castletown
    Isle Of Man
    Diretor
    40 Mill Street
    IM9 1AG Castletown
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant44920140007
    BURNETT, Gina Marie
    Coliseum Centre Dr.
    28217 Charlotte,
    2815
    North Carolina
    United States
    Diretor
    Coliseum Centre Dr.
    28217 Charlotte,
    2815
    North Carolina
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer277540180001
    ESTRADA, Nadia Patricia
    2815 Coliseum Centre
    NC 28217 North Carolina
    Sc Johnson Professional, Dr. #600
    Charlotte
    United States
    Diretor
    2815 Coliseum Centre
    NC 28217 North Carolina
    Sc Johnson Professional, Dr. #600
    Charlotte
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer244161150001
    MATTERSON, Nicholas Noel Hardwick
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer175389990001
    MELLOR, Lynval
    Denby Hall Way
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Sc Johnson Professional
    England
    Diretor
    Denby Hall Way
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Sc Johnson Professional
    England
    EnglandBritishVice President Europe200866200001
    TENTORI, Mark Ian
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    Diretor
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director119564310001
    TILLEARD, Roy William
    Avistine
    Glen Road
    IM9 4HW Colby
    Isle Of Man
    Diretor
    Avistine
    Glen Road
    IM9 4HW Colby
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishDirector10047220006
    WILLIAMSON, Andrew
    Linacre Queens Drive
    DE56 2TJ Belper
    Derbyshire
    Diretor
    Linacre Queens Drive
    DE56 2TJ Belper
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Secretary26237590001
    WILLIAMSON, Martin
    38 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 6AL Derby
    Derbyshire
    Diretor
    38 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 6AL Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director15460590003
    WILLIAMSON, Nicholas
    3447 No 1 Side Road
    Burlington
    Ontario Lr7 3x4
    Canada
    Diretor
    3447 No 1 Side Road
    Burlington
    Ontario Lr7 3x4
    Canada
    BritishCompany Director27508430001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Deb Holdings Limited
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    England
    06/04/2016
    Denby
    DE5 8JZ Ripley
    Denby Hall Way
    Derbyshire
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridade legalEngland And Wales
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    SC JOHNSON PROFESSIONAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 23/05/2014
    Entregue em 30/05/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC (Formerly Lloyds Tsb Bank PLC) as Security Trustee for Itself and Other Secured Parties (the "Security Agent")
    Transações
    • 30/05/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 26/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 31/05/2013
    Entregue em 05/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    UK trademarks number 965789 class 3 mark text altrans,number 1229159 class 3 ambisan,number 1555543 class 3 mark text aquaress (for further details of UK trademarks please refer to form MR01). Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transações
    • 05/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 26/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security accession deed
    Criado em 22/03/2010
    Entregue em 29/03/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company, or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transações
    • 29/03/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 05/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Group debenture
    Criado em 18/12/2006
    Entregue em 23/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(the "Security Agent")
    Transações
    • 23/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 05/10/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 11/03/2004
    Entregue em 18/03/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transações
    • 18/03/2004Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 11/03/2004
    Entregue em 23/03/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transações
    • 23/03/2004Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 25/08/2000
    Entregue em 07/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness liabilities and obligations which are at the 25/08/00 or may at any time thereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever to the security beneficiaries by any group company whether actually or contingently whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Securitybeneficiaries) (the Security Trustee)
    Transações
    • 07/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 27/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge and set-off
    Criado em 12/03/1998
    Entregue em 24/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All monies standing to the credit of the account or accounts of the company in the banks books.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 27/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 12/03/1998
    Entregue em 24/03/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other group company as defined therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/03/1998Registro de uma garantia (395)
    • 27/03/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of charge and set-off
    Criado em 03/11/1997
    Entregue em 19/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys as at 3/11/97 or at any time thereafter standing to the credit of the account or accounts of the companies in the banks books shall stand charged by way of fixed and specific charge.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 03/11/1997
    Entregue em 13/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise
    Breve descrição
    All that property k/a little eaton ind est t/n DY61241; all that property k/a the church house little eaton t/n DY187796; all that property k/a land to the north west side of nottingham road belper t/n DY261729 and all that property k/a land to the south east side of nottingham road belper t/n DY272596. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 03/01/1995
    Entregue em 18/01/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or dualwise limited to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 18/01/1995Registro de uma garantia (395)
    • 11/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 04/12/1990
    Entregue em 12/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee the various deeds and documents as defined in this deed
    Breve descrição
    See doc M395 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Banks and the Overdraft Bank
    • The Governor and Company of the Banks of Scotlanddraft Bank)(As Agent and Trustee for the Banks and the Over
    Transações
    • 12/12/1990Registro de uma garantia
    • 11/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 03/12/1990
    Entregue em 24/12/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the and/or dual wise limited, appor limited and presutek limited or any group company (as therein defined). Company to the chargee as agent for the banks and the overdraft bank (as therein defined) under the terms of the facilities agreement dated 4TH december 1990 on any account whatsoever.
    Breve descrição
    By way of fixed and specific charge all monies standing to the credit of the account or accounts of deb group limited with the bank of scotland.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transações
    • 24/12/1990Registro de uma garantia
    • 11/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0