INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD

INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00366295
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    • Edição de jornais (58130) / Informação e comunicação

    Onde fica INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    Endereço do escritório registrado
    39 Welbeck Street
    W1G 8DR London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INDEPENDENT NEWSPAPERS (UK) LIMITED29/04/199429/04/1994
    GREATER LONDON & ESSEX NEWSPAPERS LIMITED31/12/197731/12/1977
    ESSEX AND EAST LONDON NEWSPAPERS LIMITED03/04/194103/04/1941

    Quais são as últimas contas de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até26/12/2014

    Quais são as últimas submissões para INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Satisfação total da garantia 6

    5 páginasMR04

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 11 Welbeck Street London W1G 9XZ para 39 Welbeck Street London W1G 8DR em 10/08/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 10/07/2015 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/07/2015

    Estado do capital em 20/07/2015

    • Capital: GBP 7,226,546
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 26/12/2014

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Eamonn O'kennedy como diretor em 31/12/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 10/07/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/07/2014

    Estado do capital em 18/07/2014

    • Capital: GBP 7,226,546
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    1 páginasAA

    Término da nomeação de Vincent Crowley como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 10/07/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/07/2013

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 19/07/2013

    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    10 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * C/O 2Nd Floor 5 Jubilee Place London London SW3 3TD England* em 27/07/2012

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 10/07/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2011

    10 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de * 2 Derry Street London W8 5HF* em 17/10/2011

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Eamonn O'kennedy como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Round como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2010

    10 páginasAA

    Nomeação de Mr Richard J Mcclean como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SNODDY, Simon
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Secretário
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    159509000001
    MCCLEAN, Richard J
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Diretor
    Welbeck Street
    W1G 8DR London
    39
    England
    Northern IrelandBritish160639340001
    BRACKEN, Derek Andrew
    66 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TX London
    Secretário
    66 Solent Road
    West Hampstead
    NW6 1TX London
    British79961570002
    BURGESS, Laurence Edward
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretário
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33551470002
    MCCREERY, Stuart Alexander
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretário
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    British31612490004
    TIMMS, Roger Edward
    4 Monkhams Lane
    IG8 0NL Woodford Green
    Essex
    Secretário
    4 Monkhams Lane
    IG8 0NL Woodford Green
    Essex
    British1628510001
    BROWNING, Alec John
    78 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    Diretor
    78 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    British1628520001
    BURGESS, Laurence Edward
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    April Cottage
    Collett Road
    HP1 1HY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33551470002
    CROWLEY, Vincent Conor
    2023 Bianconi Avenue
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    Independent House
    Dublin
    Germany
    Diretor
    2023 Bianconi Avenue
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    Independent House
    Dublin
    Germany
    IrelandIrish145612030001
    EVANS, Philip Neil
    3 Poseidon Court
    E14 3UG London
    Diretor
    3 Poseidon Court
    E14 3UG London
    British27685760001
    FALLON, Ivan Gregory
    17 Kensington Mansions
    Trebovir Road
    SW5 9TF London
    Diretor
    17 Kensington Mansions
    Trebovir Road
    SW5 9TF London
    UkIrish68609380003
    GROTE, Terence Michael
    The Old White House 27 High Street
    Melbourn
    SG8 6EB Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    The Old White House 27 High Street
    Melbourn
    SG8 6EB Royston
    Hertfordshire
    British18054520001
    GWINN, Paul
    8 Roy Gardens
    IG2 7QQ Ilford
    Essex
    Diretor
    8 Roy Gardens
    IG2 7QQ Ilford
    Essex
    British13357390001
    HEALY, Liam Padraig
    Wood Lawn
    Golf Links Road
    IRISH Foxrock
    Co Dublin Eire
    Diretor
    Wood Lawn
    Golf Links Road
    IRISH Foxrock
    Co Dublin Eire
    IrelandIrish1695450001
    HOPKINS, Brendan Michael Anthony
    43 Norland Square
    W11 4PZ London
    Diretor
    43 Norland Square
    W11 4PZ London
    United KingdomBritish54628620001
    MCCREERY, Stuart Alexander
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Diretor
    5 Hills View
    Great Shelford
    CB2 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    British31612490004
    O'KENNEDY, Eamonn
    Welbeck Street
    W1G 9XZ London
    11
    England
    Diretor
    Welbeck Street
    W1G 9XZ London
    11
    England
    IrelandIrish253646050001
    PARKINSON, James Joseph
    Tor
    Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Eire
    Diretor
    Tor
    Church Road
    IRISH Killiney
    Co Dublin
    Eire
    IrelandIrish7264750001
    PROCTER, Lawrie
    11 Rectory Green
    BR3 4HX Beckenham
    Kent
    Diretor
    11 Rectory Green
    BR3 4HX Beckenham
    Kent
    British69116920001
    ROUND, Andrew John
    Oak House
    No 77 High Street
    CB4 8DR Landbeach
    Diretor
    Oak House
    No 77 High Street
    CB4 8DR Landbeach
    EnglandBritish34289090002
    TIMMS, Roger Edward
    41 Monkhams Lane
    IG8 0NN Woodford Green
    Essex
    Diretor
    41 Monkhams Lane
    IG8 0NN Woodford Green
    Essex
    British13668330001
    TINDLE, Raymond Stanley, Sir
    Devonshire House 92 West Street
    GU9 7EN Farnham
    Surrey
    Diretor
    Devonshire House 92 West Street
    GU9 7EN Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish57658900004

    INDEPENDENT NEWSPAPERS (REGIONALS) LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 11/11/2009
    Entregue em 19/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Bank PLC
    Transações
    • 19/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 23/10/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 26/08/2003
    Entregue em 03/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due by any obligor to the secured parties or to the security agent under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed charge the company's right, title and interest to the real property and the trade marks floating charge the whole of the company's undertaking and assets present or future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Agent
    Transações
    • 03/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 20/01/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 08/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge created by way of debenture
    Criado em 23/06/2003
    Entregue em 02/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as security agent on behalf of the beneficiaries (as defined) or under or pursuant to the relevant documents (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    The whole of the company's undertaking and assets present and future.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 02/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/07/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    • 10/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Floating charge created by way of debenture dated 9 july 2001 between independent news & media (UK) limited, independent news & media (northern ireland) limited, independent newspapers (publishing) limited, independent newspapers (UK) limited, independent finance PLC, independent newspapers (regionals) limited, tih (belfast) and the security agent (as defined)
    Criado em 09/07/2001
    Entregue em 17/07/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries by the company or under or pursuant to the releant documents (as defined)
    Breve descrição
    By way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets, present and future as security for payment and discharge of the secured obligations.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Agent on Behalf of the Beneficiearies (As Defined)
    Transações
    • 17/07/2001Registro de uma garantia (395)
    • 06/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 05/10/1998
    Entregue em 06/10/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 5TH october 1998
    Breve descrição
    £5,334.25 plus vat.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Geoffrey Michael Warren
    Transações
    • 06/10/1998Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 31/03/1980
    Entregue em 02/04/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    3 paradise row, london E2. Title no ngl 24039. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 02/04/1980Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0