UNION PUMP LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | UNION PUMP LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00366985 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de UNION PUMP LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica UNION PUMP LIMITED?
Endereço do escritório registrado | . Green Road Penistone S36 6BJ Sheffield |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de UNION PUMP LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED | 03/04/1998 | 03/04/1998 |
DAVID BROWN PUMPS LIMITED | 28/03/1989 | 28/03/1989 |
DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED | 22/06/1988 | 22/06/1988 |
DAVID BROWN ESTATES LIMITED | 07/05/1941 | 07/05/1941 |
Quais são as últimas contas de UNION PUMP LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2015 |
Quais são as últimas submissões para UNION PUMP LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Jeremy Wade Smeltser em 26/09/2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Balkar Sohal como diretor em 26/09/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Paul Andrew Cahill como diretor em 26/09/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Kevin Lucius Lilly como diretor em 03/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Stephen Tsoris como diretor em 03/04/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Balkar Sohal em 22/09/2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mark Edward Shanahan em 22/09/2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2014 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Christopher Brown como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Thomas Brown como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 15/05/2013 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Kevin Lucius Lilly em 01/01/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Jeremy Wade Smeltser em 01/01/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Balkar Sohal em 12/05/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mark Edward Shanahan em 15/05/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Allan Dowie como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Quem são os diretores de UNION PUMP LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHILL, Paul Andrew | Diretor | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 202085370001 | ||||
SHANAHAN, Mark Edward | Diretor | Ocean House, Towers Business Park Didsbury M20 2LY Manchester C/O Spx Europe Shared Services Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 165707440001 | ||||
SMELTSER, Jeremy Wade | Diretor | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13220 North Carolina Usa | United States | American | Cfo, Spx Flow, Inc. | 163313000001 | ||||
TSORIS, Stephen | Diretor | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | Director | 197069810001 | ||||
ASHMAN, Linda Margaret | Secretário | Blue Fields 421 Huddersfield Road, Shelley HD8 8NE Woodhouse Huddersfield West Yorkshire | British | 86730910001 | ||||||
BROWN, Thomas James | Secretário | 57 Randolph Road G11 7JJ Glasgow | British | Company Secretary | 60773560001 | |||||
COWAN, Jonathan Brandon | Secretário | 5 Warwick Avenue Hale WA15 9EA Altrincham Cheshire | British | 29591090001 | ||||||
TULLEY, Karen Ann | Secretário | Knottside Farm The Knott, Pateley Bridge HG3 5DQ Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 59112980002 | |||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Diretor | Apartment 301 Valley Mill Cottonfields Eagley Brook BL7 9DY Bolton Lancashire | England | British | Finance Director | 1876370002 | ||||
ANDREWS, Alan | Diretor | 27 Hill Top Road Salendine Nook HD3 3SW Huddersfield West Yorkshire | British | Aftermarket Director | 52101720001 | |||||
BAILEY, Derek | Diretor | 26 Pennine Rise Scissett HD8 9JE Huddersfield West Yorkshire | British | Engineering And Technical Serv | 29591110001 | |||||
BLACKWELL, Malcolm | Diretor | Pogstone House 19 Cuckstool Road Denby Dale HD8 8RF Huddersfield | United Kingdom | British | Managing Director | 40752710001 | ||||
BRADWELL, Garth Jeffrey | Diretor | 5 Nightingale Croft Thorpe Hesley S61 2UB Rotherham South Yorkshire | British | Finance Director | 66587570001 | |||||
BROWN, Christopher John | Diretor | The Grange Bent Lane Sutton In Craven BD20 7AL Keighley West Yorkshire | England | British | Group Managing Director | 1698880001 | ||||
COOK, Christopher David | Diretor | Beauchamp House Church Road CV35 8AN Sherbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Group Managing Director | 1698890001 | ||||
COWAN, Jonathan Brandon | Diretor | 5 Warwick Avenue Hale WA15 9EA Altrincham Cheshire | British | Finance Director | 29591090001 | |||||
DOWIE, Allan Cameron | Diretor | Arkaig Place Newton Mearns G77 5PH Glasgow 7 | United Kingdom | British | Finance Director | 132053460001 | ||||
ELSBORG, Anton Cecil | Diretor | Woodstock Thorpe Lane LS20 8LE Leeds West Yorkshire | England | British | Group Finance Director | 93041580001 | ||||
GARNER, Philip Frank | Diretor | 83 Barrow Road Quorn LE12 8DH Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 48137730001 | |||||
HOBBS, David John | Diretor | 1a Towngate Highburton HD8 0QP Huddersfield West Yorkshire | British | Finance Dir | 48318550001 | |||||
HOLLAND, Mark Harry | Diretor | 219 Huddersfield Road Thongsbridge HD9 3TT Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98168130001 | ||||
LILLY, Kevin Lucius | Diretor | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13220 North Carolina Usa | Usa | American | Director | 165775730001 | ||||
LODGE, Christopher Martin | Diretor | 21 Birchland Drive Killamarsh S31 8GL Sheffield South Yorkshire | British | Operations Director | 48087890001 | |||||
O'LEARY, Patrick Joseph | Diretor | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13515 Nc 28277 Usa | United States | American | Business Director | 61807850002 | ||||
PENNING, Graham Michael | Diretor | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | Vice President Of Engineering | 12354670001 | ||||
ROWLEY, Stephen Nicholas | Diretor | Pond Farm House Midway South Crosland HD4 7DA Huddersfield | British | Company Director | 47869520001 | |||||
SCHREIBER, Gregory | Diretor | 6157 Bethany Circle Richland Michigan 49083 Usa | American | President | 71227450001 | |||||
SOHAL, Balkar | Diretor | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | Chartered Accountant | 161546310001 | ||||
STRUDWICK, Tony | Diretor | 17 Broomleaf Road GU9 8DG Farnham Surrey | British | Sales Director | 38754410001 |
UNION PUMP LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Criado em 24/09/1992 Entregue em 07/10/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture | Criado em 24/01/1990 Entregue em 06/05/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90) | |
Breve descrição (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee & debenture | Criado em 24/01/1990 Entregue em 05/02/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever. | |
Breve descrição Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 27/06/1989 Entregue em 04/07/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 27/06/1989 Entregue em 30/06/1989 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 20/12/1985 Entregue em 03/01/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fixed and floating charge | Criado em 18/10/1985 Entregue em 28/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 11/10/1984 Entregue em 26/10/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 26/09/1984 Entregue em 03/09/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deposit of deeds without written instrument | Criado em 27/08/1984 Entregue em 12/09/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0