UNION PUMP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaUNION PUMP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00366985
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de UNION PUMP LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica UNION PUMP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de UNION PUMP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED03/04/199803/04/1998
    DAVID BROWN PUMPS LIMITED28/03/198928/03/1989
    DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED22/06/198822/06/1988
    DAVID BROWN ESTATES LIMITED07/05/194107/05/1941

    Quais são as últimas contas de UNION PUMP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para UNION PUMP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/05/2016 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/05/2016

    Estado do capital em 16/05/2016

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Jeremy Wade Smeltser em 26/09/2015

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Balkar Sohal como diretor em 26/09/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Paul Andrew Cahill como diretor em 26/09/2015

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/05/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/05/2015

    Estado do capital em 27/05/2015

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Término da nomeação de Kevin Lucius Lilly como diretor em 03/04/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Stephen Tsoris como diretor em 03/04/2015

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Balkar Sohal em 22/09/2014

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mark Edward Shanahan em 22/09/2014

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/05/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/06/2014

    Estado do capital em 11/06/2014

    • Capital: GBP 582,222
    SH01

    Término da nomeação de Christopher Brown como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Thomas Brown como secretário

    1 páginasTM02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/05/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Kevin Lucius Lilly em 01/01/2013

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Jeremy Wade Smeltser em 01/01/2013

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Balkar Sohal em 12/05/2013

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mark Edward Shanahan em 15/05/2013

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Allan Dowie como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de UNION PUMP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    Diretor
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Diretor
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanCfo, Spx Flow, Inc.163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Diretor
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector197069810001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Secretário
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Secretário
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Secretário
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    British29591090001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Diretor
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    ANDREWS, Alan
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAftermarket Director52101720001
    BAILEY, Derek
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishEngineering And Technical Serv29591110001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    Diretor
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishManaging Director40752710001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Diretor
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishFinance Director66587570001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Diretor
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Diretor
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director1698890001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director29591090001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Diretor
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    GARNER, Philip Frank
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    Diretor
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director48137730001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Dir48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Diretor
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Diretor
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    LODGE, Christopher Martin
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director48087890001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Diretor
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Director61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Diretor
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    ROWLEY, Stephen Nicholas
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    Diretor
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    BritishCompany Director47869520001
    SCHREIBER, Gregory
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    Diretor
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    AmericanPresident71227450001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    STRUDWICK, Tony
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    Diretor
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    BritishSales Director38754410001

    UNION PUMP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee and debenture
    Criado em 24/09/1992
    Entregue em 07/10/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 07/10/1992Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 24/01/1990
    Entregue em 06/05/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90)
    Breve descrição
    (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Bankers Trust Company
    Transações
    • 06/05/1990Registro de uma garantia
    • 30/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 24/01/1990
    Entregue em 05/02/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • First Britannia Mezzanine Capital Bv
    Transações
    • 05/02/1990Registro de uma garantia
    • 30/11/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 27/06/1989
    Entregue em 04/07/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 04/07/1989Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 27/06/1989
    Entregue em 30/06/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 30/06/1989Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 20/12/1985
    Entregue em 03/01/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/01/1986Registro de uma garantia
    Fixed and floating charge
    Criado em 18/10/1985
    Entregue em 28/10/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131).
    Pessoas com direito
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee
    Transações
    • 28/10/1985Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 11/10/1984
    Entregue em 26/10/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/10/1984Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 26/09/1984
    Entregue em 03/09/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/09/1984Registro de uma garantia
    Deposit of deeds without written instrument
    Criado em 27/08/1984
    Entregue em 12/09/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/09/1984Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0