SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED

SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00368815
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SIX CONTINENTS HOTELS & HOLIDAYS LIMITED06/08/200106/08/2001
    BASS HOTELS AND HOLIDAYS LIMITED16/09/198516/09/1985
    BASS HOLIDAYS LIMITED27/11/198427/11/1984
    PONTIN'S LIMITED20/08/194120/08/1941

    Quais são as últimas contas de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/11/2018

    16 páginasLIQ03

    Término da nomeação de Justin Bruce Robinson como diretor em 14/09/2018

    1 páginasTM01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 22/12/2017

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/11/2017

    LRESSP

    Detalhes do secretário alterados para Haysmacintyre Company Secretaries Limited em 18/12/2017

    1 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Mabry em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG em 18/12/2017

    1 páginasAD01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Michael Teasdale em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 003688150004

    5 páginasMR05

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 05/10/2017

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 03/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 03/02/2017

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    14 páginasAA

    Quem são os diretores de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secretário
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Diretor
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Diretor
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish204008350001
    BOLTON, Susan
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    10 Haygreen Close
    KT2 7TS Kingston Upon Thames
    Surrey
    British59426570001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    CRANE, Julia Alison
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    Secretário
    27 Hatton Court
    Lubbock Road
    BR7 5JQ Chislehurst
    Kent
    British46318020001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secretário
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secretário
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203613510001
    TOON, Samantha Anne
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    Secretário
    10 St.Anthonys Court
    Nightingale Lane
    SW12 8NS London
    British32930670001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Secretário
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secretário
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secretário
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Secretário
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro04131463
    125623230001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    CASTON, Robert Warwick
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    Diretor
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    British1311840002
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Diretor
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Diretor
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    British31551670001
    JACKMAN, Robert Loehr
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    Diretor
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    American35835670003
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Diretor
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Diretor
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Diretor
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Diretor
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Diretor
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritish49954790002
    RITSON, Leslie David
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    Diretor
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    British26098610002
    ROBINSON, Justin Bruce
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Diretor
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish225299130001
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Diretor
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001
    STOCKS, Nigel Peter
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    Diretor
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish147336730001
    VAN OOSTEROM, Sophie
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    Diretor
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    United KingdomDutch139801070001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Diretor
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WINTER, Richard Thomas
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    Diretor
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    United KingdomBritish6308500001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06/04/2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05385882
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 01/12/2015
    Entregue em 02/12/2015
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Societe Generale,London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent)
    Transações
    • 02/12/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 18/12/2017Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 22/05/2013
    Entregue em 03/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transações
    • 03/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 03/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage
    Criado em 20/06/2005
    Entregue em 28/06/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descrição
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transações
    • 28/06/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 20/06/2005
    Entregue em 22/06/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transações
    • 22/06/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)

    SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/11/2017Início da liquidação
    03/07/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0