SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00368815 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SIX CONTINENTS HOTELS & HOLIDAYS LIMITED | 06/08/2001 | 06/08/2001 |
| BASS HOTELS AND HOLIDAYS LIMITED | 16/09/1985 | 16/09/1985 |
| BASS HOLIDAYS LIMITED | 27/11/1984 | 27/11/1984 |
| PONTIN'S LIMITED | 20/08/1941 | 20/08/1941 |
Quais são as últimas contas de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/11/2018 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Término da nomeação de Justin Bruce Robinson como diretor em 14/09/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 22/12/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Haysmacintyre Company Secretaries Limited em 18/12/2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Mabry em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG em 18/12/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Michael Teasdale em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 003688150004 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 05/10/2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 03/02/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Diretor | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Diretor | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| BOLTON, Susan | Secretário | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretário | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretário | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| CRANE, Julia Alison | Secretário | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | 46318020001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretário | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secretário | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203613510001 | |||||||||||
| TOON, Samantha Anne | Secretário | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | 32930670001 | ||||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Secretário | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretário | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretário | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CASTON, Robert Warwick | Diretor | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | 1311840002 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Diretor | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Diretor | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRAHAM, Ian Christopher | Diretor | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | 31551670001 | ||||||||||
| JACKMAN, Robert Loehr | Diretor | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | 35835670003 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Diretor | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Diretor | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Diretor | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PRINCE, Ryan David | Diretor | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| REES, Sally Irene | Diretor | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | 49954790002 | |||||||||
| RITSON, Leslie David | Diretor | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | 26098610002 | ||||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Diretor | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Diretor | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Diretor | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| VAN OOSTEROM, Sophie | Diretor | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 139801070001 | |||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Diretor | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WINTER, Richard Thomas | Diretor | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | 6308500001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon Acquisition Limited | 06/04/2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 01/12/2015 Entregue em 02/12/2015 | Pendente | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 22/05/2013 Entregue em 03/06/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage | Criado em 20/06/2005 Entregue em 28/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 20/06/2005 Entregue em 22/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
SC HOTELS & HOLIDAYS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0