A.E.S. ENGINEERING LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | A.E.S. ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00392743 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
- fabricação de outras máquinas de uso geral n.e.c. (28290) / Indústrias transformadoras
Onde fica A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| AURORA ENGINEERS' SUPPLIES LIMITED | 31/12/1977 | 31/12/1977 |
| AURORA PACKINGS AND SEALS LIMITED | 25/01/1945 | 25/01/1945 |
Quais são as últimas contas de A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 20/09/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 04/10/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 20/09/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 5 | 2 páginas | MR05 | ||||||||||
Nomeação de Mr James Stuart Welsh como diretor em 03/11/2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/09/2025 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2024 | 68 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Julie Ann Kenny como diretor em 21/02/2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorando e estatutos | 24 páginas | MA | ||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 2 páginas | SH10 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/09/2024 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2023 | 69 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia 7 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 9 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 8 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 10 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 11 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 003927430012 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 21/03/2024 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2022 | 72 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 21/03/2023 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/11/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2021 | 69 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/11/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2020 | 73 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Dame Julie Ann Kenny como diretor em 16/08/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICKINSON, Claire Louise | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 260947760001 | |||||||
| BISHOP, Richard Mark | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 74729420002 | |||||
| DICKINSON, Claire Louise | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 201137570001 | |||||
| HAMILTON, James Neil | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | Scotland | British | 242466120001 | |||||
| LOBLEY, Ian Matthew | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 48956790004 | |||||
| REA, Christopher John | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 6929300002 | |||||
| SHAW, Stephen Martin | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 78291310001 | |||||
| WELSH, James Stuart | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 201138150001 | |||||
| BRIDGE, Gordon Wilson | Secretário | Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road High Bradfield S6 6LJ Sheffield | British | 5201640001 | ||||||
| CALDWELL, John Christopher | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 174766900001 | |||||||
| HODSON, Neville John | Secretário | High Reach High Bradfield S6 6LG Sheffield | British | 45516800002 | ||||||
| MACDONALD, Neil Andrew | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 160450800001 | |||||||
| MALLOY, Craig | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 191150780001 | |||||||
| REA, Christopher John | Secretário | Holcombe Green Lane S60 3AT Rotherham South Yorkshire | Northern Irish | 6929300001 | ||||||
| STEWART, John Hugh | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 211877130001 | |||||||
| SULLIVAN, Richard Edward | Secretário | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | 247710320001 | |||||||
| ANDERSON, Ronald | Diretor | 2584 Maryhill Road G20 0TJ Glasgow Strathclyde Scotland | Irish | 44731660001 | ||||||
| BEATY, Kenneth Robert | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 116798240001 | |||||
| BISHOP, Richard Mark | Diretor | 16 Buddon Lane Quorn LE12 8AA Loughborough | England | British | 74729420002 | |||||
| BLAGDEN, Simon Paul | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 128545130006 | |||||
| BLAGDEN, Simon Paul | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 196053150001 | |||||
| BRIDGE, Gordon Wilson | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 5201640001 | |||||
| BRIDGE, Gordon Wilson | Diretor | Primrose Cottage Farm Kirk Edge Road High Bradfield S6 6LJ Sheffield | England | British | 5201640001 | |||||
| CALDWELL, John Christopher | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 83552520001 | |||||
| CONGER, Hamdi | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 107322570001 | |||||
| GRIFFITHS, Carolyn Jane | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 257384810001 | |||||
| GUPPY, Colin Desmond | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 106774760001 | |||||
| HAGUE, William Jefferson | Diretor | Maire House Brough Hall Brough Park DL10 7PJ Richmond North Yorkshire | United Kingdom | British | 24253830001 | |||||
| HODSON, Neville John | Diretor | High Reach High Bradfield S6 6LG Sheffield | British | 45516800002 | ||||||
| KENNY, Julie Ann, Dame | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 25615210002 | |||||
| LEE, Nigel Haywood Wilton | Diretor | The Beeches Firbeck S81 8JT Worksop Nottinghamshire | British | 3432610001 | ||||||
| MACDONALD, Neil Andrew | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 3696630003 | |||||
| MALLOY, Craig | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 191150650001 | |||||
| PICKLES, Thomas Richard | Diretor | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | England | British | 134826920001 | |||||
| REA, Rosalie | Diretor | Holcombe Green Lane Moorgate S60 3AT Rotherham South Yorkshire | England | British | 17408470001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de A.E.S. ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 06/04/2016 | Palace Street SW1E 5JD London 16 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mr Christopher John Rea | 06/04/2016 | Global Technology Centre Bradmarsh Business Park S60 1BZ Mill Close Rotherham South Yorkshire | Não | ||||||||||
Nacionalidade: Northern Irish País de residência: England | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| 3i Investments Plc | 06/04/2016 | Palace Street SW1E 5JD London 16 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0