HICKING PENTECOST LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | HICKING PENTECOST LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00406925 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de HICKING PENTECOST LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica HICKING PENTECOST LIMITED?
Endereço do escritório registrado | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8FD Bristol England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de HICKING PENTECOST LIMITED?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/12/2024 |
Próximas contas vencem em | 30/09/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para HICKING PENTECOST LIMITED?
Última declaração de confirmação elaborada até | 12/06/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 26/06/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 12/06/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para HICKING PENTECOST LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhes do secretário alterados para Coats Patons Limited em 30/01/2025 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Memorando e estatutos | 24 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Jeffrey Stuart Bertram Soal como diretor em 31/12/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Nicholas James Kidd como diretor em 31/12/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de James Douglas Gunningham como diretor em 31/12/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Peter Oaten como diretor em 31/12/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Richard Charles Reade como diretor em 31/12/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Alteração dos detalhes de I.P. Clarke & Company Limited como pessoa com controlo significativo em 03/10/2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE England para The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS13 8FD em 03/10/2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Coats Patons Limited como diretor em 27/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de I P Clarke & Company Limited como diretor em 27/09/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr James Douglas Gunningham como diretor em 27/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Nicholas James Kidd como diretor em 27/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Quem são os diretores de HICKING PENTECOST LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COATS PATONS LIMITED | Secretário | G2 1AL Glasgow 1 George Square |
| 115295980001 | ||||||||||
KERMALLI, Arif | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | British | Director | 203519190001 | ||||||||
OATEN, Andrew Peter | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | British | Director | 303797130001 | ||||||||
SOAL, Jeffrey Stuart Bertram | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | Scotland | British | Director | 303798660001 | ||||||||
ALDRIDGE, Gemma Jane Constance | Secretário | 54 Crown Street HA2 0HR Harrow On The Hill Middlesex | British | Company Secretary | 144966000001 | |||||||||
GIBSON, Carolyn Ann | Secretário | 10 Hanger Hill KT13 9XR Weybridge Surrey | British | 59736770001 | ||||||||||
JENKINS, David Huw | Secretário | 25 Wingfield Close The Common CF37 4AB Pontypridd | British | 76742540002 | ||||||||||
JENKINS, David Huw | Secretário | 25 Wingfield Close The Common CF37 4AB Pontypridd | British | 76742540002 | ||||||||||
JONES, Ceri Marc | Secretário | Fairmead 26 Smithies Avenue CF64 5SS Sully Vale Of Glamorgan | British | 145523250001 | ||||||||||
ROSE, Belinda | Secretário | 45 Reginald Road HA6 1EF Northwood Middlesex | British | 90092080001 | ||||||||||
STEPHENS, Julia | Secretário | Chapel Lodge Old Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JW Winchester Hampshire | British | Company Secretary | 63984570001 | |||||||||
ALDRIDGE, Gemma Jane Constance | Diretor | 54 Crown Street HA2 0HR Harrow On The Hill Middlesex | England | British | Company Secretary | 144966000001 | ||||||||
BEVAN, Roger | Diretor | The Shires 20 Woodbank HP27 0TS Loosley Row Buckinghamshire | England | British | Director | 99478770001 | ||||||||
CARLSEN, John Erik Marius | Diretor | Llwyndu Court NP7 7HG Abergavenny Gwent | Wales | British | Company Director | 3339450001 | ||||||||
DAVIES, Stephen William | Diretor | Craigower 8 Whitewell Road BB5 6DA Accrington Lancashire | British | Chartered Accountant | 1295100002 | |||||||||
DAVIES, Tudor Griffith | Diretor | Home Farm The Hendre NP25 5HH Monmouth Gwent | Wales | Welsh | Company Director | 68085230001 | ||||||||
FLOWER, Martin Charles | Diretor | The Pound Cookham SL6 9QD Berkshire Little Morton | England | British | Director | 135172110001 | ||||||||
GROSSART, Hamish Mcleod | Diretor | West Court Newton EH52 6QH Broxburn West Lothian | British | Banker | 37900003 | |||||||||
GUNNINGHAM, James Douglas | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | British | Director | 204284950001 | ||||||||
HEALY, Christopher William | Diretor | 50 Marville Road Fulham SW6 7BD London | United Kingdom | British | Group Secretary | 58484770001 | ||||||||
JONES, Ceri Marc | Diretor | Fairmead 26 Smithies Avenue CF64 5SS Sully Vale Of Glamorgan | United Kingdom | British | Company Director | 145523250001 | ||||||||
KANTOR, Kazimiera Teresa | Diretor | 27 Springhill Road OX5 1RX Begbroke Oxfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 98839680001 | ||||||||
KERSHAW, Nicholas John | Diretor | Horderley SY7 8HR Craven Arms Shropshire | British | Director | 102878890001 | |||||||||
KIDD, Nicholas James | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | British | Director | 189356380001 | ||||||||
LEA, Jonathan David | Diretor | Little Manor Fulmer Road SL9 7EF Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 67105270002 | ||||||||
LISTER, John Thomas | Diretor | 1 The Paddock Lisvane CF14 0AY Cardiff | Wales | British | Company Director | 1555540001 | ||||||||
LITTLE, Simon Charles Mainwaring | Diretor | Beaufort House Bannerdown Road Batheaston BA1 7ND Bath | England | British | Company Director | 33084040003 | ||||||||
MCVICKER, John Alexander | Diretor | Ormiston, 86 Portglenone Road BT41 3EH Randalston County Antrim | Northern Ireland | British | Company Director | 143196590001 | ||||||||
MEREDITH, Gillian Carol | Diretor | 38 Boyn Hill Avenue SL6 4HA Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 143863560001 | ||||||||
PERKS, Gordon Maxwell, Dr | Diretor | 41 The Orchard Sandhills Lane GU25 4DT Virginia Water Surrey | British | Director | 73587800001 | |||||||||
READE, Richard Charles | Diretor | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | England | British | Company Director | 194091110001 | ||||||||
SAUNT, Timothy Patrick | Diretor | 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 58873990003 | ||||||||
STEPHENS, Julia | Diretor | Chapel Lodge Old Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JW Winchester Hampshire | British | Company Secretary | 63984570001 | |||||||||
WHITLOW, Henry Donald | Diretor | 115 Hathaway Heights 36207 Anniston Alabama Usa | American | Company Director | 59822050001 | |||||||||
COATS PATONS LIMITED | Diretor | West Regent Street G2 2BA Glasgow Cornerstone 107 |
| 115295980001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de HICKING PENTECOST LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.P. Clarke & Company Limited | 06/04/2016 | Bridgwater Road BS13 8FD Bristol The Pavilions England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
HICKING PENTECOST LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 31/07/1996 Entregue em 07/08/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Floating charge | Criado em 05/01/1996 Entregue em 18/01/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 28/09/1990 Entregue em 19/10/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a:- factory and office premises at west street, alford, lincolnshire. And the proceeds of sale thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 28/09/1990 Entregue em 19/10/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a:- factory and office premises at west street, alford, lincolnshire. And the proceeds of sale thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 29/06/1987 Entregue em 15/07/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture dated 20TH february 1986. | |
Breve descrição Room 607/616 sixth floor langham house regent st. London W1 land & buldings to the south east side of portland road shirebrook t/n dy 82227. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 03/04/1986 Entregue em 10/04/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land & buildings lying to the south east of portland rd shirebrook derbyshrie (title no dy 82227) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 03/04/1986 Entregue em 10/04/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a alford maltings west st, alford lincs and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 03/04/1986 Entregue em 10/04/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property k/a factory & office premises west st alford lincs and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 20/02/1986 Entregue em 24/02/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Breve descrição Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital, book & other debts. (See doc M122). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Supplemental trust deed | Criado em 11/02/1985 Entregue em 20/02/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £300,000 7 1/2 percent debenture stock 1986/91 of the company secured by a trust deed 28-1-66 and deeds supplemental thereto | |
Breve descrição Rooms 607/616 6TH floor langham house regent street london rooms 373/376 princess house eastcastle st london by way of specific equitable charge all estates or interests in any f/hold and l/hold property and/or the proceeds of sale thereof all book and other debts goodwill and the benefit of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 26/01/1984 Entregue em 03/02/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all other property & assets present & future inc. Goodwill & bookdebts. Legal mortgage over l/h property k/a rooms 607/616 6TH floor langham house, regent street london W1. L/h property k/a rooms 373/376 princess house eastcastle street, london W1. And/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Series of debentures | Criado em 03/02/1966 Entregue em 03/02/1966 | Totalmente satisfeita | ||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0