HICKING PENTECOST LIMITED

HICKING PENTECOST LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHICKING PENTECOST LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00406925
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HICKING PENTECOST LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HICKING PENTECOST LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de HICKING PENTECOST LIMITED?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2024
    Próximas contas vencem em30/09/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para HICKING PENTECOST LIMITED?

    Última declaração de confirmação elaborada até12/06/2025
    Próxima declaração de confirmação vence26/06/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até12/06/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para HICKING PENTECOST LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Detalhes do secretário alterados para Coats Patons Limited em 30/01/2025

    1 páginasCH04

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Memorando e estatutos

    24 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Re: directors given authority to authorise matters giving rise to an actual or potential conflict 26/03/2024
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022

    7 páginasAA

    Nomeação de Mr Jeffrey Stuart Bertram Soal como diretor em 31/12/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas James Kidd como diretor em 31/12/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de James Douglas Gunningham como diretor em 31/12/2022

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Andrew Peter Oaten como diretor em 31/12/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Richard Charles Reade como diretor em 31/12/2022

    1 páginasTM01

    Alteração dos detalhes de I.P. Clarke & Company Limited como pessoa com controlo significativo em 03/10/2022

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 4 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1FE England para The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS13 8FD em 03/10/2022

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    7 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 12/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Coats Patons Limited como diretor em 27/09/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de I P Clarke & Company Limited como diretor em 27/09/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr James Douglas Gunningham como diretor em 27/09/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Nicholas James Kidd como diretor em 27/09/2019

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de HICKING PENTECOST LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COATS PATONS LIMITED
    G2 1AL Glasgow
    1 George Square
    Secretário
    G2 1AL Glasgow
    1 George Square
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registroSC35975
    115295980001
    KERMALLI, Arif
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritishDirector203519190001
    OATEN, Andrew Peter
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritishDirector303797130001
    SOAL, Jeffrey Stuart Bertram
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    ScotlandBritishDirector303798660001
    ALDRIDGE, Gemma Jane Constance
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    Secretário
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    BritishCompany Secretary144966000001
    GIBSON, Carolyn Ann
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    Secretário
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    British59736770001
    JENKINS, David Huw
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    Secretário
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    British76742540002
    JENKINS, David Huw
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    Secretário
    25 Wingfield Close
    The Common
    CF37 4AB Pontypridd
    British76742540002
    JONES, Ceri Marc
    Fairmead 26 Smithies Avenue
    CF64 5SS Sully
    Vale Of Glamorgan
    Secretário
    Fairmead 26 Smithies Avenue
    CF64 5SS Sully
    Vale Of Glamorgan
    British145523250001
    ROSE, Belinda
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    Secretário
    45 Reginald Road
    HA6 1EF Northwood
    Middlesex
    British90092080001
    STEPHENS, Julia
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    Secretário
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Secretary63984570001
    ALDRIDGE, Gemma Jane Constance
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    Diretor
    54 Crown Street
    HA2 0HR Harrow On The Hill
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Secretary144966000001
    BEVAN, Roger
    The Shires
    20 Woodbank
    HP27 0TS Loosley Row
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Shires
    20 Woodbank
    HP27 0TS Loosley Row
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector99478770001
    CARLSEN, John Erik Marius
    Llwyndu Court
    NP7 7HG Abergavenny
    Gwent
    Diretor
    Llwyndu Court
    NP7 7HG Abergavenny
    Gwent
    WalesBritishCompany Director3339450001
    DAVIES, Stephen William
    Craigower 8 Whitewell Road
    BB5 6DA Accrington
    Lancashire
    Diretor
    Craigower 8 Whitewell Road
    BB5 6DA Accrington
    Lancashire
    BritishChartered Accountant1295100002
    DAVIES, Tudor Griffith
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    Diretor
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    WalesWelshCompany Director68085230001
    FLOWER, Martin Charles
    The Pound
    Cookham
    SL6 9QD Berkshire
    Little Morton
    Diretor
    The Pound
    Cookham
    SL6 9QD Berkshire
    Little Morton
    EnglandBritishDirector135172110001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Diretor
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    BritishBanker37900003
    GUNNINGHAM, James Douglas
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritishDirector204284950001
    HEALY, Christopher William
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    Diretor
    50 Marville Road
    Fulham
    SW6 7BD London
    United KingdomBritishGroup Secretary58484770001
    JONES, Ceri Marc
    Fairmead 26 Smithies Avenue
    CF64 5SS Sully
    Vale Of Glamorgan
    Diretor
    Fairmead 26 Smithies Avenue
    CF64 5SS Sully
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritishCompany Director145523250001
    KANTOR, Kazimiera Teresa
    27 Springhill Road
    OX5 1RX Begbroke
    Oxfordshire
    Diretor
    27 Springhill Road
    OX5 1RX Begbroke
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director98839680001
    KERSHAW, Nicholas John
    Horderley
    SY7 8HR Craven Arms
    Shropshire
    Diretor
    Horderley
    SY7 8HR Craven Arms
    Shropshire
    BritishDirector102878890001
    KIDD, Nicholas James
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritishDirector189356380001
    LEA, Jonathan David
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Little Manor
    Fulmer Road
    SL9 7EF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director67105270002
    LISTER, John Thomas
    1 The Paddock
    Lisvane
    CF14 0AY Cardiff
    Diretor
    1 The Paddock
    Lisvane
    CF14 0AY Cardiff
    WalesBritishCompany Director1555540001
    LITTLE, Simon Charles Mainwaring
    Beaufort House Bannerdown Road
    Batheaston
    BA1 7ND Bath
    Diretor
    Beaufort House Bannerdown Road
    Batheaston
    BA1 7ND Bath
    EnglandBritishCompany Director33084040003
    MCVICKER, John Alexander
    Ormiston, 86 Portglenone Road
    BT41 3EH Randalston
    County Antrim
    Diretor
    Ormiston, 86 Portglenone Road
    BT41 3EH Randalston
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director143196590001
    MEREDITH, Gillian Carol
    38 Boyn Hill Avenue
    SL6 4HA Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    38 Boyn Hill Avenue
    SL6 4HA Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant143863560001
    PERKS, Gordon Maxwell, Dr
    41 The Orchard
    Sandhills Lane
    GU25 4DT Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    41 The Orchard
    Sandhills Lane
    GU25 4DT Virginia Water
    Surrey
    BritishDirector73587800001
    READE, Richard Charles
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Diretor
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    EnglandBritishCompany Director194091110001
    SAUNT, Timothy Patrick
    1 The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    Middlesex
    Diretor
    1 The Square
    Stockley Park
    UB11 1TD Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director58873990003
    STEPHENS, Julia
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Chapel Lodge
    Old Stockbridge Road Sutton Scotney
    SO21 3JW Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Secretary63984570001
    WHITLOW, Henry Donald
    115 Hathaway Heights
    36207 Anniston
    Alabama
    Usa
    Diretor
    115 Hathaway Heights
    36207 Anniston
    Alabama
    Usa
    AmericanCompany Director59822050001
    COATS PATONS LIMITED
    West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Cornerstone 107
    Diretor
    West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    Cornerstone 107
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registroSC35975
    115295980001

    Quem são as pessoas com controle significativo de HICKING PENTECOST LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    I.P. Clarke & Company Limited
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    06/04/2016
    Bridgwater Road
    BS13 8FD Bristol
    The Pavilions
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroUk Companies House
    Número de registro93416
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    HICKING PENTECOST LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 31/07/1996
    Entregue em 07/08/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/08/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/09/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Floating charge
    Criado em 05/01/1996
    Entregue em 18/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Northern Bank Limited
    Transações
    • 18/01/1996Registro de uma garantia (395)
    • 27/12/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 28/09/1990
    Entregue em 19/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a:- factory and office premises at west street, alford, lincolnshire. And the proceeds of sale thereof.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/10/1990Registro de uma garantia
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 28/09/1990
    Entregue em 19/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a:- factory and office premises at west street, alford, lincolnshire. And the proceeds of sale thereof.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/10/1990Registro de uma garantia
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/06/1987
    Entregue em 15/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture dated 20TH february 1986.
    Breve descrição
    Room 607/616 sixth floor langham house regent st. London W1 land & buldings to the south east side of portland road shirebrook t/n dy 82227.
    Pessoas com direito
    • Industrial Developments Board for Northern Ireland
    Transações
    • 15/07/1987Registro de uma garantia
    • 06/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/04/1986
    Entregue em 10/04/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land & buildings lying to the south east of portland rd shirebrook derbyshrie (title no dy 82227) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 10/04/1986Registro de uma garantia
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/04/1986
    Entregue em 10/04/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a alford maltings west st, alford lincs and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 10/04/1986Registro de uma garantia
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/04/1986
    Entregue em 10/04/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a factory & office premises west st alford lincs and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 10/04/1986Registro de uma garantia
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 20/02/1986
    Entregue em 24/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descrição
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital, book & other debts. (See doc M122).
    Pessoas com direito
    • Department of Economic Development
    Transações
    • 24/02/1986Registro de uma garantia
    • 04/08/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Criado em 11/02/1985
    Entregue em 20/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £300,000 7 1/2 percent debenture stock 1986/91 of the company secured by a trust deed 28-1-66 and deeds supplemental thereto
    Breve descrição
    Rooms 607/616 6TH floor langham house regent street london rooms 373/376 princess house eastcastle st london by way of specific equitable charge all estates or interests in any f/hold and l/hold property and/or the proceeds of sale thereof all book and other debts goodwill and the benefit of any licences.
    Pessoas com direito
    • Schroder Executor & Trustee Company Limited
    Transações
    • 20/02/1985Registro de uma garantia
    • 22/06/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/01/1984
    Entregue em 03/02/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all other property & assets present & future inc. Goodwill & bookdebts. Legal mortgage over l/h property k/a rooms 607/616 6TH floor langham house, regent street london W1. L/h property k/a rooms 373/376 princess house eastcastle street, london W1. And/or the proceeds of sale thereof.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/02/1984Registro de uma garantia
    • 15/04/1993Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 04/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Series of debentures
    Criado em 03/02/1966
    Entregue em 03/02/1966
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • Schroder Executer & Trustee Co. LTD
    Transações
    • 03/02/1966Registro de uma garantia
    • 06/02/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0