RLP OLD CO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRLP OLD CO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00408816
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RLP OLD CO LIMITED?

    • outras atividades de fabricação n.e.c. (32990) / Indústrias transformadoras

    Onde fica RLP OLD CO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RLP OLD CO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED22/04/199922/04/1999
    LEDBURY PRESERVES LIMITED11/10/199611/10/1996
    INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED22/01/199622/01/1996
    HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED23/04/194623/04/1946

    Quais são as últimas contas de RLP OLD CO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para RLP OLD CO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Andrew John Mcdonald como diretor em 23/05/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Duncan Neil Leggett como diretor em 23/05/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 11/11/2016

    1 páginasTM01

    Restauração por ordem judicial

    5 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 30/09/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/10/2012

    Estado do capital em 02/10/2012

    • Capital: GBP 3,000,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name11/06/2012

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15
    change-of-name11/06/2012

    Alteração do nome" por resolução

    NM01

    Término da nomeação de Antony Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Emmett Mcevoy como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Suzanne Wise como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01
    capital

    Resoluções

    Delete mem 07/10/2011
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade

    2 páginasCC02

    Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/08/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Ms Suzanne Elizabeth Wise em 01/08/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Simon Nicholas Wilbraham em 01/08/2011

    1 páginasCH03

    Quem são os diretores de RLP OLD CO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BROWN, Philip Damian
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British120200002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretário
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretário
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BOYD, James Macleod
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    Diretor
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    British21379830001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    COOK, Bernard
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    Diretor
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    British12836850001
    COURTNEY, Paul
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Diretor
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish222001800001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Diretor
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    HARDY, John
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Diretor
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British49690000002
    HOLROYD, Dean
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British64875220001
    HUNTER, Muir Ian
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    Diretor
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    British65861860001
    JOLLANS, Kenneth Richard
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    Diretor
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    EnglandBritish73630340002
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Diretor
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Diretor
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    LEWIS, David
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69920630001
    LEWIS, John
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    Diretor
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    British21379850001
    MANN, Peter Charles
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Diretor
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    EnglandBritish48283310001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish120645920001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002

    RLP OLD CO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/2004
    Entregue em 06/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 06/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Criado em 11/09/2000
    Entregue em 23/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transações
    • 23/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 29/04/1986
    Entregue em 14/05/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Breve descrição
    Land and buildings at aber park flint clwyd.
    Pessoas com direito
    • Delyn Borough Council
    Transações
    • 14/05/1986Registro de uma garantia
    • 20/07/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/01/1983
    Entregue em 19/01/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 19/01/1983Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 17/10/1977
    Entregue em 21/10/1977
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 21/10/1977Registro de uma garantia
    • 11/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/04/1976
    Entregue em 05/05/1976
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/05/1976Registro de uma garantia
    • 27/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 17/10/1974
    Entregue em 24/10/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/10/1974Registro de uma garantia
    • 21/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge on contract for sale
    Criado em 17/10/1974
    Entregue em 24/10/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/10/1974Registro de uma garantia
    • 21/11/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0