RLP OLD CO LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | RLP OLD CO LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00408816 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RLP OLD CO LIMITED?
- outras atividades de fabricação n.e.c. (32990) / Indústrias transformadoras
Onde fica RLP OLD CO LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RLP OLD CO LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED | 22/04/1999 | 22/04/1999 |
| LEDBURY PRESERVES LIMITED | 11/10/1996 | 11/10/1996 |
| INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED | 22/01/1996 | 22/01/1996 |
| HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED | 23/04/1946 | 23/04/1946 |
Quais são as últimas contas de RLP OLD CO LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2011 |
Quais são as últimas submissões para RLP OLD CO LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Andrew John Mcdonald como diretor em 23/05/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Duncan Neil Leggett como diretor em 23/05/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 11/11/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Restauração por ordem judicial | 5 páginas | AC92 | ||||||||||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/09/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Antony Smith como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Emmett Mcevoy como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Término da nomeação de Suzanne Wise como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||
Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade | 2 páginas | CC02 | ||||||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/08/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Ms Suzanne Elizabeth Wise em 01/08/2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Simon Nicholas Wilbraham em 01/08/2011 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Quem são os diretores de RLP OLD CO LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| LEGGETT, Duncan Neil | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 194179970001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BROWN, Philip Damian | Secretário | 154 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | 120200002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretário | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Secretário | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Secretário | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretário | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secretário | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Secretário | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Diretor | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| BOYD, James Macleod | Diretor | Wych Cottage Common Lane S42 7AN Cutthorpe Derbyshire | British | 21379830001 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Diretor | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Diretor | 42 Windmill Rise Kingston Hill KT2 7TU Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570001 | ||||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Diretor | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| COOK, Bernard | Diretor | Flat C 1 Benbow Court Hammersmith W6 0AT London | British | 12836850001 | ||||||
| COURTNEY, Paul | Diretor | 9 Churchill Drive Newtown GL20 8EL Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 222001800001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Diretor | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| HARDY, John | Diretor | 18 Turnpike Avenue GL12 7SD Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 49690000002 | ||||||
| HOLROYD, Dean | Diretor | 15 Clarence Square GL50 4JN Cheltenham Gloucestershire | British | 64875220001 | ||||||
| HUNTER, Muir Ian | Diretor | Fairhaven Akeferry Road Westwoodside DN9 2DS Doncaster South Yorkshire | British | 65861860001 | ||||||
| JOLLANS, Kenneth Richard | Diretor | Maple Heights Broad Street GL19 3BN Hartpury Gloucestershire | England | British | 73630340002 | |||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Diretor | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Diretor | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| LEWIS, David | Diretor | Pennyfield 9 Pitch Pond Close Knotty Green HP9 1XY Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69920630001 | |||||
| LEWIS, John | Diretor | Riseley Mill Cottage Risely Mill RG7 1XU Reading Berks | British | 21379850001 | ||||||
| MANN, Peter Charles | Diretor | 2 Orchard View Falfield GL12 8DG Wotton Under Edge Gloucestershire | England | British | 48283310001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Diretor | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCMAHON, Ian Reid | Diretor | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Diretor | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 120645920001 | |||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Diretor | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Diretor | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 |
RLP OLD CO LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 26/07/2004 Entregue em 06/08/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Criado em 11/09/2000 Entregue em 23/09/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 29/04/1986 Entregue em 14/05/1986 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Breve descrição Land and buildings at aber park flint clwyd. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 12/01/1983 Entregue em 19/01/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 17/10/1977 Entregue em 21/10/1977 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 29/04/1976 Entregue em 05/05/1976 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 17/10/1974 Entregue em 24/10/1974 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge on contract for sale | Criado em 17/10/1974 Entregue em 24/10/1974 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0