GORSEY SIX LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGORSEY SIX LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00421037
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GORSEY SIX LIMITED?

    • (5212) /

    Onde fica GORSEY SIX LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GORSEY SIX LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ECLIPSE BLINDS LIMITED14/07/199414/07/1994
    ASHLEY GROUP PLC09/09/198809/09/1988
    ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C31/12/197931/12/1979
    THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED07/10/194607/10/1946

    Quais são as últimas contas de GORSEY SIX LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2005

    Quais são as últimas submissões para GORSEY SIX LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    3 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/06/2010

    5 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Kpmg Restructuring 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL em 22/12/2009

    1 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/12/2009

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/06/2009

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/12/2008

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 07/12/2008

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários

    5 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Contas anuais preparadas até 31/12/2005

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Contas anuais preparadas até 31/12/2004

    13 páginasAA

    legacy

    3 páginas363s

    legacy

    1 páginas288c

    Contas anuais preparadas até 31/12/2003

    15 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas anuais preparadas até 31/12/2002

    15 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    7 páginas363s

    Contas anuais preparadas até 31/12/2001

    16 páginasAA

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02
    2 páginasCERTNM

    Quem são os diretores de GORSEY SIX LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    Secretário
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    British9962100001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    Diretor
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish28937370012
    WILSON, Stephen Graham
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    Diretor
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish23638320002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Secretário
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    GILLIES, Malcolm John
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    Secretário
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    British1381960001
    STABLES, Jane Margaret
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    Secretário
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    British41059230001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    British57834870001
    BLACK, James Edward
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    Diretor
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    ScotlandUnited Kingdom35816690001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Diretor
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    BUTLER, Anthony Bertram
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    Diretor
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    British18439630001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Diretor
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Diretor
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    JOHN, Christopher
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    Diretor
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    British71834620003
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    British34964530002
    LANGLANDS, John Thomson
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    Diretor
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    ScotlandBritish722090001
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritish10878930001
    MACDONALD, William
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    Diretor
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    British539830001
    MAYDON, Peter John
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    Diretor
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish5988360001
    MCNEIL, Robert
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    Diretor
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish31415950001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Diretor
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MONSERRAT MESANZA, Miguel
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Diretor
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945210001
    ORTON, Anthony Stanley
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    Diretor
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    British Canadian12605660001
    RODGER, James Roy
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Diretor
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British48535040002
    THOMAS, John Alan
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    British802790001
    TIPPER, Christopher Stuart
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    Diretor
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    British46918370001
    URCELAY ALONSO, Antonio
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Diretor
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945230001
    WHITE, James
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    British28464050001

    GORSEY SIX LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 29/11/1995
    Entregue em 08/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Undertaking and all property and assets.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 08/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 26/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/11/1995
    Entregue em 02/12/1995
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 02/12/1995Registro de uma garantia (395)
    A deed of charge
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 18/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994
    Breve descrição
    (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • James Mcneil
    Transações
    • 18/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of charge
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 18/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descrição
    The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • James Mcneil
    Transações
    • 18/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of charge
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 18/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descrição
    All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Robert Mcneil
    Transações
    • 18/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of charge
    Criado em 30/06/1994
    Entregue em 18/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Breve descrição
    By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Robert Mcneil
    Transações
    • 18/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 03/09/1993
    Entregue em 10/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge
    Breve descrição
    By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395).
    Pessoas com direito
    • Secured Parties (As Defined).
    Transações
    • 10/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment agreement
    Criado em 31/08/1988
    Entregue em 05/09/1988
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment
    Breve descrição
    All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50).
    Pessoas com direito
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transações
    • 05/09/1988Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 31/08/1988
    Entregue em 05/09/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge
    Breve descrição
    (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transações
    • 05/09/1988Registro de uma garantia
    • 12/03/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    GORSEY SIX LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    17/11/2010Data de dissolução
    08/12/2006Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profissional
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Profissional
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0