HEADLAM GROUP PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHEADLAM GROUP PLC
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 00460129
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HEADLAM GROUP PLC?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HEADLAM GROUP PLC?

    Endereço do escritório registrado
    Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HEADLAM GROUP PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HEADLAM, SIMS & COGGINS PUBLIC LIMITED COMPANY18/10/194818/10/1948

    Quais são as últimas contas de HEADLAM GROUP PLC?

    VencidoNão
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2024
    Próximas contas vencem em30/06/2025
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2023

    Qual é o status da última declaração de confirmação para HEADLAM GROUP PLC?

    Última declaração de confirmação elaborada até11/06/2025
    Próxima declaração de confirmação vence25/06/2025
    Última declaração de confirmação
    Próxima declaração de confirmação elaborada até11/06/2024
    VencidoNão

    Quais são as últimas submissões para HEADLAM GROUP PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Keith Graeme Edelman como diretor em 28/02/2025

    1 páginasTM01
    XDXSXYBC

    Registo da garantia 004601290013, criada em 04/10/2024

    23 páginasMR01
    XDD7V0I0

    Resoluções

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de supressão dos direitos de preferência

    RES11
    capital

    Resolução de autorização para compra de um número de ações

    RES09
    capital

    Resoluções

    Re: short notice of a meeting other than an annual general meeting 23/05/2024
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração de confirmação apresentada em 11/06/2024 sem atualizações

    3 páginasCS01
    XD54LYVV

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen Clive Bird em 01/03/2024

    2 páginasCH01
    XD45MI7N

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2023

    218 páginasAA
    AD24AJ3K

    Endereço do domicílio registado alterado de PO Box 1 Gorsey Lane Coleshill Birmingham West Midlands B46 1LW para Gorsey Lane Coleshill Birmingham B46 1JU em 01/03/2024

    1 páginasAD01
    XCXZYAP5

    Término da nomeação de Caroline Louise Farbridge como secretário em 14/12/2023

    1 páginasTM02
    XCISI5BF

    Nomeação de Ms Alison Jane Margaret Hughes como secretário em 14/12/2023

    2 páginasAP03
    XCISI59N

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2022

    255 páginasAA
    AC7IMB29

    Declaração de confirmação apresentada em 11/06/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01
    XC5JIOL7

    Nomeação de Mr Adam David Phillips como diretor em 25/05/2023

    2 páginasAP01
    XC5JIM1F

    Término da nomeação de Adam David Phillips como diretor em 25/05/2023

    1 páginasTM01
    XC5JIH9E

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de supressão dos direitos de preferência

    RES11
    capital

    Resolução de autorização para compra de um número de ações

    RES09
    capital

    Resoluções

    Re: short notice of a meeting other than an annual general meeting 25/05/2023
    RES13
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 260,397.45
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    22/05/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    AC3SBHM3

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 257,547.45
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    02/05/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction
    AC28M4EQ

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 238,797.8
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    17/04/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction
    AC11KS6P

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 249,997.8
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    17/04/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction
    AC11KS6X

    Nomeação de Mr Adam David Phillips como diretor em 20/03/2023

    2 páginasAP01
    XBZSHVMW

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 200,663.1
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    23/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABXVMQG2

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 211,345.55
    4 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    23/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABXVMQFE

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 216,497.8
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    23/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABXVMQFM

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 227,397.8
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    23/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABXVMQFU

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 152,329.8
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    06/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABWM0RTU

    Compra de ações próprias. Ações compradas para tesouraria:

    • Capital: GBP 164,291.5
    3 páginasSH03
    Anotações
    DataAnotação
    06/02/2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.
    ABWM0RTE

    Quem são os diretores de HEADLAM GROUP PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HUGHES, Alison Jane Margaret
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Secretário
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    317327920001
    BIRD, Jemima Chloe
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    United KingdomBritishBrand Marketing Strategist286898810001
    BIRD, Stephen Clive
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive116132970003
    HUBBARD, Karen Rachael
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector 281755350001
    PAYNE, Christopher Richard
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector238065750002
    PHILLIPS, Adam David
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector249325810002
    WILLIAMS, Robin George Walton
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director39500990006
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    254024260001
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    Secretário
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary9962100001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    300080130001
    WARD, Sarah Louise
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    238548180001
    WILSON, Stephen Graham
    86 Copt Heath Drive
    Knowle
    B93 9PB Solihull
    West Midlands
    Secretário
    86 Copt Heath Drive
    Knowle
    B93 9PB Solihull
    West Midlands
    British23638320001
    PRISM COSEC LIMITED
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secretário
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro05533248
    116519070002
    PRISM COSEC LIMITED
    St George's Business Park
    207 Brooklands Road
    KT13 0TS Weybridge
    Elder House
    Surrey
    England
    Secretário
    St George's Business Park
    207 Brooklands Road
    KT13 0TS Weybridge
    Elder House
    Surrey
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro5533248
    116519070002
    ALDRIDGE, Amanda
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director244315480001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector57834870001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    Diretor
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector28937370012
    DICKENS, Roger Joseph
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    6 Woodbourne Road
    Edgbaston
    B15 3QH Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector63562150001
    EASTGATE, Andrew Keith
    1 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JE Birmingham
    Summerfields
    Diretor
    1 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JE Birmingham
    Summerfields
    EnglandEnglishDirector25768830002
    EDELMAN, Keith Graeme
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    Diretor
    Coleshill
    B46 1JU Birmingham
    Gorsey Lane
    United Kingdom
    EnglandBritishNon-Executive Director143145410001
    GROVE, David Leslie
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    Diretor
    Badgers Holt, Rookery Lane
    Lowsonford
    B95 5EP Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector4174280001
    JUDGE, Antony Raymond
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director223565110001
    KING, Simon Theodore
    Gorsey Lane Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    PO BOX 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    Gorsey Lane Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    PO BOX 1
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector283539850001
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    BritishChief Executive34964530002
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritishDirector(Non Executive)10878930001
    LAWRENCE, Philip James
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector105225890001
    LITTLEY, Alison Louise
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director197621700001
    O LEARY, Michael Kevin
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector96516470003
    PETERS, Richard Wade
    Deloitte & Touche Llp Stonecutter
    Court 1 Stonecutter Street
    EC4A 4TR London
    Diretor
    Deloitte & Touche Llp Stonecutter
    Court 1 Stonecutter Street
    EC4A 4TR London
    EnglandBritishDirector141369540001
    PHILLIPS, Adam David
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector249325810002
    REDDYHOUGH, David
    Grasmere Lodge
    Marston Trussell
    LE16 9TP Market Harborough
    Leicestershire
    Diretor
    Grasmere Lodge
    Marston Trussell
    LE16 9TP Market Harborough
    Leicestershire
    BritishOperations Director-Safety Footwear54394960001
    WALDRON, Graham
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    PO BOX 1 Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector32596320003
    WILSON, Stephen Graham
    Gorsey Lane Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    PO BOX 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Diretor
    Gorsey Lane Coleshill
    B46 1LW Birmingham
    PO BOX 1
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector240972860002

    HEADLAM GROUP PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 04/10/2024
    Entregue em 07/10/2024
    Pendente
    Breve descrição
    Site a, highway point, gorsey lane, coleshill with title number WK382385 as described in part I of schedule 1 of the legal mortgage.. Land to the north of gorsey lane, coleshill, birmingham with title number WK448902 as described in part I of schedule 1 of the legal mortgage.. Land lying to the north of gorsey lane, coleshill with title number WK408968 as described in part I of schedule 1 of the legal mortgage.. For further details of the land charged, refer to the legal mortgage.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 07/10/2024Registro de uma garantia (MR01)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Criado em 08/11/1996
    Entregue em 26/11/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to missives between the company and the said chargee dated 22 october 1996
    Breve descrição
    All and whole subjects forming part of the lands and estate of woodhall in the county of lanark extending to 1.883 hectares or thereby part and portion of the subjects under t/n LAN86593.
    Pessoas com direito
    • Mossend Developments Limited
    Transações
    • 26/11/1996Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 10/11/1995
    Entregue em 21/11/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a land and buildings on south east side of newton close park farm industrial estate wellingborough northamptonshire t/no: NN89334 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 21/11/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 12/10/1995
    Entregue em 20/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/as land and buildings on north east side of aylesford way pipers lane thatcham berkshire.t/no.BK320961 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 13/09/1993
    Entregue em 20/09/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    56 stewarts road wellingborough northamptonshire t/n nn 152575 and/or the proceeds of sale and asigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/09/1993Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 17/05/1993
    Entregue em 24/05/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit b arrow business park shawbank road hereford and worcester t/n HW116242.and/or the proceeds of sale.assignment of goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 24/05/1993Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 17/10/1989
    Entregue em 02/11/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the east side of riverside way bedford road nothampton title no nn 32266 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 02/11/1989Registro de uma garantia
    • 31/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 17/10/1989
    Entregue em 30/10/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit D2 huncoat industrial estate, accrington, hyndburn, lancashire title no la 556851 goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 30/10/1989Registro de uma garantia
    • 01/09/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/05/1989
    Entregue em 31/05/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 31/05/1989Registro de uma garantia
    • 14/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 17/05/1988
    Entregue em 20/05/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 20/05/1988Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 04/10/1984
    Entregue em 11/10/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold warehouse premises station road, finedan, kettering, northamptonshire. Titel no. NN4145.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/10/1984Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 24/09/1984
    Entregue em 02/10/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold 30 reening street mansfield. Nottinghamshire title no nt 133762.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/10/1984Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 24/09/1984
    Entregue em 28/09/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 28/09/1984Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0