C&UCO PROPERTIES LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | C&UCO PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00464224 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de C&UCO PROPERTIES LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Endereço do escritório registrado | 4 Matthew Parker Street SW1H 9HQ London |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
BOURNE ASSOCIATION LIMITED | 03/02/1949 | 03/02/1949 |
Quais são as últimas contas de C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/12/2024 |
Próximas contas vencem em | 30/09/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Última declaração de confirmação elaborada até | 02/06/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 16/06/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 02/06/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Nomeação de Mr Julian Marc Ellacott como diretor em 12/02/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Lord Dominic Robert Andrew Johnson como diretor em 12/02/2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Andrew Michael Gordon Sharpe como diretor em 12/02/2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Richard Quentin Fuller como diretor em 12/02/2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Notificação de Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch como pessoa com controlo significativo em 02/11/2024 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessação de Rishi Sunak como pessoa com controlo significativo em 02/11/2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Término da nomeação de Richard John Holden como diretor em 08/07/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Richard Quentin Fuller como diretor em 08/07/2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2023 | 19 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 02/06/2024 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr John Edward Belsey como diretor em 17/11/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Jeremy Michael Edward Moss como diretor em 17/11/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Greg William Hands como diretor em 13/11/2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Richard John Holden como diretor em 13/11/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2022 | 18 páginas | AA | ||
Cessação de Darren James Mott como pessoa com controlo significativo em 02/06/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessação de Stanley Fink como pessoa com controlo significativo em 02/06/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessação de Oliver James Dowden como pessoa com controlo significativo em 02/06/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 02/06/2023 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Lord Andrew Michael Gordon Sharpe como diretor em 21/11/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 04/02/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de T&H Secretarial Services Limited como secretário em 31/01/2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nomeação de Right Honourable Greg William Hands como diretor em 07/02/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Sydney John Peter Booth como diretor em 21/11/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Oliver James Dowden como diretor em 24/06/2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Quem são os diretores de C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELSEY, John Edward | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 319011150001 | ||||||||
BOOTH, Sydney John Peter | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 305791550001 | ||||||||
ELLACOTT, Julian Marc | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | United Kingdom | British | Actury | 80024770005 | ||||||||
JOHNSON, Dominic Robert Andrew, Lord | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | United Kingdom | British | Co Chairman | 142155960001 | ||||||||
MORAN, Christopher John, Dr | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | Financier | 65462650003 | ||||||||
GRIFFITHS, Sally Jane | Secretário | 83 Brian Avenue CR2 9NJ South Croydon Surrey | British | 91601070001 | ||||||||||
JONES, Donald Whittaker | Secretário | The Half Acre Great Hormead SG9 0NP Buntingford Herts | British | 23293130001 | ||||||||||
TROWER, Anthony Gosselin | Secretário | Stansteadbury Ware Herts | British | 23293110001 | ||||||||||
T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | Bunhill Row EC1Y 8YZ London 3 United Kingdom |
| 64631620001 | ||||||||||
T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | Sceptre Court 40 Tower Hill EC3N 4DX London | 64631620001 | |||||||||||
BOARDMAN, Thomas Gray, Lord | Diretor | The Manor House NN6 6HX Welford Northamptonshire | British | Banker | 23293120001 | |||||||||
CASTLE, Stephen Charles | Diretor | 4 George Close SS8 9PU Canvey Island Essex | England | British | Director | 48692960003 | ||||||||
CHAPLIN, Malcolm Hilbery, Sir | Diretor | Bacons Farm House Hall Lane CM4 9NU Ingatestone Essex | British | Chartered Surveyor | 36310100004 | |||||||||
DAY, Simon Charles | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | England | British | None | 174370080002 | ||||||||
DOWDEN, Oliver James | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | England | British | Member Of Parliament | 295399200001 | ||||||||
FELDMAN, Andrew Simon, Lord | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 26112790003 | ||||||||
FINK, Stanley, Lord | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | England | British | None | 118515860001 | ||||||||
FULLER, Richard Quentin | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | None | 108210860002 | ||||||||
GREEN, Norman Denis | Diretor | Millbank SW1P 4DP London 30 United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 103148790001 | ||||||||
HANDS, Greg William, Right Honourable | Diretor | SW1H 9HQ London 4 Matthew Parker Street United Kingdom | United Kingdom | British | Conservative Party Chair /Minister Without Potfoli | 159169100001 | ||||||||
HOLLAND MARTIN, Robert George | Diretor | 18 Tite Street SW3 4HZ London | United Kingdom | British | Company Director | 51684150001 | ||||||||
HUTTON, Christopher | Diretor | Pippins Sneephorst Lane TN12 9NV Marden | British | Finance Director | 93543810001 | |||||||||
JOHN HOLDEN, Richard | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | United Kingdom | British | None | 316342770001 | ||||||||
JONES, Donald Whittaker | Diretor | The Half Acre Great Hormead SG9 0NP Buntingford Herts | British | Solicitor | 23293130001 | |||||||||
JUDGE, Paul Rupert, Sir | Diretor | Grange Farm Elmbridge WR9 0DA Droitwich Worcestershire | British | Company Director | 33015750002 | |||||||||
KEYMER, Gordon Charles | Diretor | Courtlands Rockfield Road RH8 0EJ Oxted Surrey | England | British | Company Director | 3152910001 | ||||||||
KING, Geoffrey Howard Burgess | Diretor | 29 Pennington Drive KT13 9RU Weybridge Surrey | British | Chartered Accountant | 8144220001 | |||||||||
LEWIS, Brandon Kenneth, Sir | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | England | British | Member Of Parliament | 173895400001 | ||||||||
MACGREGOR, Mark Christopher | Diretor | 50 Warwick Square SW1V 2AJ London | British | Chief Executive | 14427880002 | |||||||||
MANNS, Noel George Herbert, Mr. | Diretor | 66 Bolingbroke Road Brook Green W14 0AH London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 46616800002 | ||||||||
MARLAND OF ODSTOCK, Jonathan Peter, Lord | Diretor | Millbank SW1P 4DP London 30 | England | British | Director | 35373240003 | ||||||||
MCISAAC, Ian | Diretor | Millbank SW1P 4DP London 30 | England | British | Chartered Accountant | 2995350003 | ||||||||
MCLOUGHLIN, Patrick Allen, Rt Hon Lord | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | England | British | Director | 213792760001 | ||||||||
MILLING, Amanda Anne | Diretor | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | England | British | Member Of Parliament | 275952420001 | ||||||||
MONBIOT, Raymond Geoffrey | Diretor | Millbank SW1P 4DP London 30 | England | British | Consultant | 113478330001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de C&UCO PROPERTIES LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado |
---|---|---|---|
Olukemi Olufunto Adegoke Badenoch | 02/11/2024 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 United Kingdom | Não |
Nacionalidade: British País de residência: United Kingdom | |||
Natureza do controle
| |||
The Rt Hon Rishi Sunak | 24/10/2022 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
The Rt Hon Mary Elizabeth Truss | 05/09/2022 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Oliver James Dowden | 05/04/2022 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Mr Darren James Mott | 26/10/2020 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Miss Amanda Anne Milling | 26/10/2020 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
The Rt Hon Alexander Boris De Pfeffel Johnson | 24/07/2019 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Mr Brandon Kenneth Lewis | 30/01/2018 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Rt Hon Lord Patrick Allen Mcloughlin | 08/09/2016 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Rt Hon Theresa Mary May | 13/07/2016 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Lord Stanley Fink | 06/04/2016 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Mr Simon Charles Day | 06/04/2016 | Matthew Parker Street SW1H 9HQ London 4 | Sim |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
|
C&UCO PROPERTIES LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Charge over deposits | Criado em 09/03/2007 Entregue em 20/03/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £2,500,000 due or to become due from the company to | |
Breve descrição A first fixed charge over any sums deposited or to be deposited in any deposit account. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 10/04/2006 Entregue em 21/04/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The property with t/no NGL428559. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Equitable mortgage | Criado em 29/03/2006 Entregue em 12/04/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All shares and related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 29/03/2006 Entregue em 12/04/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição 32 smith square london t/n NGL428559 together with all rights in all buildings, structures, erections, fixtures and fittings assignments of rental income, occupational leases and other documents, insurance and external hedging agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 03/05/2005 Entregue em 05/05/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Land and buildings at 32 smith square london t/no NGL428559 fixed charge its interest in any present and future insurances in respect of the property and the proceeds of such insurances,rental income,service charge and any insurance rent from the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 12/08/2004 Entregue em 14/08/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição 32 smith square, london t/n NGL428559. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 26/01/1984 Entregue em 01/02/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 32 smith sq westminster & buildings, all fixed plant, machinery & fixtur es tn ngl 428559. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Memorandum of deposit of deeds | Criado em 21/04/1981 Entregue em 12/05/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 32 smith square & 67 tufton street, london SW1. Title no: ln 171604. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Memorandum of deposit of deeds | Criado em 21/11/1980 Entregue em 28/11/1980 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a deed of guarantee dated 21.11.80 | |
Breve descrição L/H property comprised in a lease dated 26.8.58 between the london county council & limes property investments limited together with all fixtures fixed plant machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0