OEM PUBLIC LIMITED COMPANY

OEM PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOEM PUBLIC LIMITED COMPANY
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 00477051
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (7011) /

    Onde fica OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Endereço do escritório registrado
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    OFFICE AND ELECTRONIC MACHINES P L C10/01/195010/01/1950

    Quais são as últimas contas de OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2006

    Quais são as últimas submissões para OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    11 páginasLIQ10
    YBDKIUUZ

    Resoluções

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 04/03/2011

    LRESEX

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    15 páginasLIQ14
    YBAR26DE

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2022

    15 páginasLIQ03
    YAWNM4PM

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600
    YA7TIPT5

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2021

    14 páginasLIQ03
    YA013JH4

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2020

    16 páginasLIQ03
    A90OMTYH

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2015

    23 páginas4.68
    A88L9JW3

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2016

    16 páginasLIQ03
    A84GRM02

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2017

    25 páginasLIQ03
    A84GRLZU

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2019

    17 páginasLIQ03
    A819VA1N

    Nomeação de um liquidador voluntário

    4 páginas600
    A79LJPBN

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    13 páginasLIQ10
    A79LJPBV

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2018

    18 páginasLIQ03
    A71RW3AG

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2017

    15 páginas4.68
    A629NME8

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 13/01/2014

    17 páginas4.68
    A31H3D0Z

    Endereço do domicílio registado alterado de * Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London Ew 1Yw* em 30/01/2013

    2 páginasAD01
    A20OW4CY

    Pedido de insolvência

    Insolvency:form 4.38 - cert of removal of liquidator
    1 páginasLIQ MISC
    A20OW4DE

    Pedido de insolvência

    Insolvency:form 4.38 - cert of removal
    1 páginasLIQ MISC
    A20OW4D6

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600
    A20OW4DM

    Notificação de cessação de atividade como liquidatário voluntário

    1 páginas4.40
    A2070S8I

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 03/03/2012

    14 páginas4.68
    A18NNGSX

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    23 páginas4.20
    AYT6ESDQ

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação

    LRESEX

    Quem são os diretores de OEM PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    NOONAN, Robert Patrick Byrne, Mr.
    Maistir Gaoithe
    Cill Airne
    IRISH Co Kerry
    Republic Of Ireland
    Diretor
    Maistir Gaoithe
    Cill Airne
    IRISH Co Kerry
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishCompany Director145842200001
    TURNER, Malcolm Robin
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    Diretor
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    United KingdomBritishDirector60293070001
    CHATER, Catherine Mary
    68b Park Mansions
    Knightsbridge
    SW1X 7QT London
    Secretário
    68b Park Mansions
    Knightsbridge
    SW1X 7QT London
    British68315130001
    MAY, Ian Edward Stewart
    Cherwell 60a Leybourne Park
    Kew Gardens
    TW9 3HA Richmond
    Surrey
    Secretário
    Cherwell 60a Leybourne Park
    Kew Gardens
    TW9 3HA Richmond
    Surrey
    British33376850001
    MCGURRAN, Brendon
    High Street
    BR3 1EB Beckenham
    130
    Kent
    Secretário
    High Street
    BR3 1EB Beckenham
    130
    Kent
    156205850001
    MCGURRAN, Brendon
    50 Lansdowne Court
    Brighton Road
    CR8 2BE Purley
    Surrey
    Secretário
    50 Lansdowne Court
    Brighton Road
    CR8 2BE Purley
    Surrey
    British106721670001
    SCHNEIDER, Brian Steven
    50 Regents Park Road
    NW1 7SX London
    Secretário
    50 Regents Park Road
    NW1 7SX London
    BritishCompany Secretary9787160001
    DOUGLAS, Charles Paul Murray
    99 Cambridge Road
    West Wimbledon
    SW20 0PU London
    Diretor
    99 Cambridge Road
    West Wimbledon
    SW20 0PU London
    EnglandBritishSolicitor102256160001
    GILCHRIST, Robert Ian
    2 Wells Close
    BN7 3DA Plumpton Green
    East Sussex
    Diretor
    2 Wells Close
    BN7 3DA Plumpton Green
    East Sussex
    United KingdomBritishCo Director14712980001
    HAWKINS, Douglas George
    Alehouse Farm
    Bodle Street
    BN27 4UB Hailsham
    East Sussex
    Diretor
    Alehouse Farm
    Bodle Street
    BN27 4UB Hailsham
    East Sussex
    United KingdomNew ZealanderCo Director14712990001
    MAY, Ian Edward Stewart
    Cherwell 60a Leybourne Park
    Kew Gardens
    TW9 3HA Richmond
    Surrey
    Diretor
    Cherwell 60a Leybourne Park
    Kew Gardens
    TW9 3HA Richmond
    Surrey
    EnglandBritishAccountant33376850001
    SCHNEIDER, Brian Steven
    50 Regents Park Road
    NW1 7SX London
    Diretor
    50 Regents Park Road
    NW1 7SX London
    BritishCo Director9787160001
    THEOPHILUS, John Angus
    8 Beaumond Green
    SO23 8GF Winchester
    Hampshire
    Diretor
    8 Beaumond Green
    SO23 8GF Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant62899290004

    OEM PUBLIC LIMITED COMPANY possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 14/07/2008
    Entregue em 21/07/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    F/H property being 103 camley street, london t/no NGL405971. All rental income, all fixtures and fittings and all plant and machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • London & Newcastle (Soho) Limited
    Transações
    • 21/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 16/12/2008Nomeação de um administrador ou gerente (405 (1))
    • 103/06/2010Notificação de cessação de atividade como administrador ou gerente (LQ02)
      • Número do processo 1
    Legal mortgage
    Criado em 29/08/2006
    Entregue em 06/09/2006
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from el rocio investments limited (the borrower) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The property k/a 103 camley street t/no NGL405971 and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transações
    • 06/09/2006Registro de uma garantia (395)
    • 16/01/2009Nomeação de um administrador ou gerente (405 (1))
    • 217/06/2010Notificação de cessação de atividade como administrador ou gerente (LQ02)
      • Número do processo 2
    Charge by way of assignment
    Criado em 03/06/2005
    Entregue em 17/06/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The rental income.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 17/06/2005Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 03/06/2005
    Entregue em 17/06/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a 103 camley street t/no NGL405971. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) PLC
    Transações
    • 17/06/2005Registro de uma garantia (395)
    Legal charge
    Criado em 19/10/2004
    Entregue em 21/10/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the comapany and prime trust corporation as trestees of el rocio trust to the chargee
    Breve descrição
    All that leasehold property at 103 camley street london t/n NGL405971.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 21/10/2004Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 31/07/2003
    Entregue em 12/08/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property at 9 woburn walk and 12 dukes road london WC1 t/no 392247 and NGL509113. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 12/08/2003Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 05/02/1998
    Entregue em 10/02/1998
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • Coutts & Company
    Transações
    • 10/02/1998Registro de uma garantia (395)
    Sub-charge
    Criado em 13/10/1995
    Entregue em 28/10/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a sale agreement of even date
    Breve descrição
    All monies secured by the deed of charge and guarantee dated 13 october 1995 created by davies street properties limited in favour of the company and a deed of charge dated 13 october 1995 created by interchange investments (culverhouse cross) limited in favour of the company.
    Pessoas com direito
    • David Martin Maxfield Dutton
    Transações
    • 28/10/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 06/02/1995
    Entregue em 14/02/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from tanson investment holdings inc. To the chargee under the terms of the loan agreement dated 27TH july 1994 and/or any security document referred to therein or in connection with any facility
    Breve descrição
    The company as trustee charged to the agent on behalf of itself and the banks by way of legal mortgage the property k/a 103 camley street london NW1 t/n-NGL405971. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited as Trustee for Itself and the Banks and Lendinginstitutions from Time to Time
    Transações
    • 14/02/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit deed
    Criado em 28/10/1994
    Entregue em 03/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 28TH october 1994 (as defined)
    Breve descrição
    The sum of £1530000. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Finning Equipment Hire Limited
    Transações
    • 03/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 07/03/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 14/09/1988
    Entregue em 20/09/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 20/09/1988Registro de uma garantia
    • 02/07/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    OEM PUBLIC LIMITED COMPANY possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1Administrador judicial/gestor nomeado
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Mark Francis Creamer
    St Martins Court, 10 Paternoster Row
    EC4M 7HP London
    Administrador judicial/gestor
    St Martins Court, 10 Paternoster Row
    EC4M 7HP London
    Jeremy Lock
    St Martins Court, 10 Paternoster Row
    London
    Administrador judicial/gestor
    St Martins Court, 10 Paternoster Row
    London
    2Administrador judicial/gestor nomeado
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Jonathan Howard Gershinson
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Administrador judicial/gestor
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Ania Packman
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    Administrador judicial/gestor
    27 Soho Square
    W1D 3AY London
    3
    DataTipo
    04/03/2011Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Profissional
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Profissional
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Richard Patrick Brewer
    Highfield Court Tollgate
    Chandler'S Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    Profissional
    Highfield Court Tollgate
    Chandler'S Ford
    SO53 3TY Eastleigh
    Hampshire
    Matthew Richard Meadley Wild
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Profissional
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    David James Green
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Profissional
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Alexander Kinninmonth
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Profissional
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0