ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração de confirmação
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED
    Estado da empresaAtiva
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00521510
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    • (4521) /

    Onde fica ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RYAN UTILITY SERVICES LIMITED20/11/200020/11/2000
    D.J. RYAN & SONS LIMITED07/07/195307/07/1953

    Quais são as últimas contas de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2009
    Próximas contas vencem em30/09/2010
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2008

    Qual é o status da última declaração de confirmação para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    VencidoSim
    Última declaração de confirmação elaborada até17/10/2016
    Próxima declaração de confirmação vence31/10/2016
    VencidoSim

    Qual é o status da última declaração anual para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual
    VencidoSim

    Quais são as últimas submissões para ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Término da nomeação de Lee James Mills como diretor em 28/09/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Timothy Francis George como secretário em 28/09/2018

    2 páginasTM02

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Término da nomeação de Andrew Wilkins como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 17/10/2009 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/10/2009

    Estado do capital em 22/10/2009

    • Capital: GBP 1,449,628
    SH01
    Anotações
    DataAnotação
    05/12/2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2007

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a
    Anotações
    DataAnotação
    05/12/2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    11 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a
    Anotações
    DataAnotação
    05/12/2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 05/12/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2006

    5 páginasAA

    legacy

    15 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COFFEY, Stephanie Helen
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    Secretário
    53 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LY Reading
    Berkshire
    British81328280002
    FORSTER, Garry James
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    Secretário
    Pilgrim Cottage
    Path Hill
    RG8 7RE Goring Heath
    Oxfordshire
    British38750850004
    GEORGE, Timothy Francis
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    Secretário
    Blackbarn House Main Street
    Bishampton
    WR10 2NH Pershore
    Worcestershire
    British24075160004
    HIGGINS, Caroline Patricia
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    Secretário
    Flat 10
    7 Aubert Park
    N5 1TL London
    British88102970001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Secretário
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    British101833160001
    STONES, Michael John
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    Secretário
    23 Muirfield Close
    Fulwood
    PR2 7EA Preston
    Lancashire
    British68468490001
    ARMSTRONG, Neil Patrick
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Diretor
    4 Euxton Hall Gardens
    Euxton
    PR7 6PB Chorley
    Lancashire
    Irish104897110001
    BROOKES, Philip
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    Diretor
    Tudor House
    Lime Tree Avenue
    LS23 6DP Boston Spa
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89559990001
    BROWN, David Robertson
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    Diretor
    11 Dorchester Road
    Fixby
    HD2 2JZ Huddersfield
    United KingdomBritish39067610002
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Diretor
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish11806560001
    CAROLAN, Peter Vincent
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Diretor
    272 Leigh Road
    Worsley
    M28 1LF Manchester
    Irish62299930001
    COCKER, Neil David
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    Diretor
    5 Rossett Close
    Kingsmead
    CW9 8WP Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish260158230001
    DARBYSHIRE, John Peter
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    Diretor
    12 Salisbury Drive
    M25 0HU Prestwich
    Manchester
    British69930320002
    FOX, Kenneth
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    Diretor
    5 Sandiacre
    Standish
    WN6 0TJ Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish15540580001
    FRASER, Richard
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    Diretor
    4 Severn Hill
    Fulwood
    PR2 3RD Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish79090001
    GREENHALGH, Donald
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    Diretor
    The Hayricks
    Bolton Road
    PR6 9HN Anderton
    Lancashire
    British47084170002
    GREENOUGH, Michael Robert
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    Diretor
    Millstone Cottage
    Bolton Road
    PR6 9HJ Anderton
    Lancashire
    British53010640001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    Diretor
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritish44883010002
    JACKSON, Andrew Philip
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    Diretor
    6 Sparvells
    Eversley
    RG27 0QG Hook
    Hampshire
    EnglandBritish7921750002
    LANSOM, Stewart Paul
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    Diretor
    23 Park Street
    FY8 5LU Lytham
    Lancashire
    British79070008
    LAVELLE, Dominic Joseph
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    Diretor
    2 West Grove
    SE10 8QT London
    Flat 3
    United KingdomBritish137285750001
    LAWLESS, Dennis Arthur
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    Diretor
    14 Sevenoaks
    PR7 3NS Chorley
    Lancashire
    British46658890003
    LEACH, William Anthony
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    Diretor
    17 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    British66732560001
    MEADOWS, John
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    Diretor
    39 Beech Walk
    Pennington
    WN7 3LL Leigh
    Lancashire
    EnglandBritish101833160001
    MEMMOTT, Robert William
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Diretor
    Oak Lodge 29 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    British109306950001
    MILLS, Lee James
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Diretor
    4 Kings Court
    CM23 2AA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish53951880001
    O'BRIEN, Neil Christopher
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Diretor
    Alexandra House
    11 St Catherine Drive Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    British58219210001
    ROWAN, Michael William
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    Diretor
    Jinbabyne 1 Field Farm Drive
    Edingale
    B79 9LF Tamworth
    Staffordshire
    British72210350002
    RYAN, Daniel Joseph
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    Diretor
    Button Mill
    Inglewhite
    PR3 2LE Preston
    Lancashire
    British1472220001
    RYAN, John Timothy Anthony
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Diretor
    Bank Hall
    Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    British39428900001
    RYAN, Michael Bernard
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    Diretor
    Stafford House 102 Victoria Road
    Fulwood
    PR2 4NN Preston
    Lancashire
    British779240001
    SIMCOCK, Barry
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    Diretor
    24 Poplar Drive
    ST3 3AZ Blurton
    Staffordshire
    British74253700001
    WILKINS, Andrew Michael
    PR25
    Diretor
    PR25
    United KingdomBritish125411390001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Diretor
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007

    ALFRED MCALPINE UTILITY SERVICES NW LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Chattels mortgage
    Criado em 05/09/2001
    Entregue em 05/09/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattles plant machinery, 16 compressor & generator systems, 2 x computer servers (for further details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 05/09/2001Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 12/02/1992
    Entregue em 21/02/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Premises situate in station road pembroke dyfed.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 21/02/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/01/1992
    Entregue em 05/02/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the north west side of rough hey road preston lancashire t/n la 585346.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/01/1992
    Entregue em 05/02/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the north east side of rough hey road, preston, lancashire. T/n la 525 287.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 27/01/1992
    Entregue em 05/02/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All those premises known as longridge foundry, inglewhite road, (formerly higher lane) longridge, lancashire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 27/01/1992
    Entregue em 05/02/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    (Please see doc form M395 reference M198C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/02/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/07/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Credit agreement
    Criado em 05/04/1991
    Entregue em 16/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 172590.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Breve descrição
    All right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance whereof are set out on form 395 (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 16/04/1991Registro de uma garantia
    • 10/02/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 24/01/1990
    Entregue em 08/02/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future includin book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 08/02/1990Registro de uma garantia
    • 10/02/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/08/1988
    Entregue em 01/09/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Premises situated off rough hey road, preston.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 01/09/1988Registro de uma garantia
    • 10/02/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/04/1988
    Entregue em 14/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the north east side of rough hey road preston.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 14/04/1988Registro de uma garantia
    • 10/02/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 14/12/1971
    Entregue em 22/12/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and premises at longridge foundry, longridge in the county of lancaster with all fixtures.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 22/12/1971Registro de uma garantia
    • 10/02/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0