GENTRA LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGENTRA LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00544337
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GENTRA LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica GENTRA LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GENTRA LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROYAL TRUST BANK03/11/198603/11/1986
    ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE)08/02/195508/02/1955

    Quais são as últimas contas de GENTRA LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para GENTRA LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/02/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 24/02/2019 com atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para P Keith Hyde em 05/12/2018

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Ricky Tang em 05/12/2018

    2 páginasCH01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2017

    10 páginasAA

    Alteração dos detalhes de Gentra Holdings Company como pessoa com controlo significativo em 03/08/2018

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England para Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW em 03/08/2018

    1 páginasAD01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/02/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    9 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 24/02/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    12 páginasAA

    Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 24/02/2016

    22 páginasRP04

    Declaração anual preparada até 24/02/2016 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital13/04/2016

    Estado do capital em 13/04/2016

    • Capital: GBP 123,714,259
    SH01
    Anotações
    DataAnotação
    27/04/2016Clarification A second filed AR01 was registered on 27/04/2016

    Detalhes do secretário alterados para Allen Yi em 11/03/2014

    1 páginasCH03

    Nomeação de Ricky Tang como diretor em 08/02/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Bryan Kenneth Davis como diretor em 08/02/2016

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    11 páginasAA

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 18/07/2014

    • Capital: GBP 123,714,259
    3 páginasSH01

    Endereço do domicílio registado alterado de , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA para C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD em 25/09/2015

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 24/02/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/03/2015

    Estado do capital em 20/03/2015

    • Capital: GBP 108,866,959
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    10 páginasAA

    Quem são os diretores de GENTRA LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    YI, Allen
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    Secretário
    Bay Street, Suite 330
    Toronto
    181
    Ontario M5j 2t3
    Canada
    British187547370001
    HYDE, P Keith
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Diretor
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    CanadaCanadian105505500001
    TANG, Ricky
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Diretor
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    United StatesCanadian206973950002
    GREGORY, Philip Charles
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    Secretário
    Mulberry House
    26 North Grove Highgate
    N6 4SL London
    British33287640001
    HYDE, P Keith
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Secretário
    26 Hambly Avenue
    Toronto
    Ontario M4e 2r6
    Canada
    Canadian105505500001
    IRONSIDE, Simon Anthony
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    Secretário
    2 Orchard Mews
    Southgate Grove Islington
    N1 5BS London
    British31215710001
    MOODY, Patricia Joan
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    Secretário
    8 Riverdene
    HA8 9TD Edgware
    Middlesex
    British5286990001
    MULROY, Kieran Finbarr
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Secretário
    31 White Lodge Crescent
    L4C 9A1 Richmond Hill
    Ontario
    Canada
    Canadian48720010001
    WICKS, Martin Theodore
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    Secretário
    206 Britannia Drive 431
    Grand Cayman Box 30616 Smb
    Cayman Islands
    British62800470003
    BARR, Brian Ernest
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    Diretor
    C/O Falconbridge Limited
    181 Bay Street Suite 200 Bce Place
    Toronto
    Ontario M5j2t3
    Canada
    British Canadian7708890001
    BRIERLEY, Michael Charles
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    Diretor
    45 Carisbrooke Gardens
    LE2 3PR Leicester
    Leicestershire
    British5287010001
    CAPE, Edmund Andrew
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Diretor
    75 Rosedale Heights Drive
    Toronto Ontario
    FOREIGN Canada
    Canadian36523210001
    CORNELISSEN, Michael Adriaan
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Diretor
    2061 Lakeshore Road East
    FOREIGN Oakville
    Ontario L6j 1x4
    Canada
    Canadian7708900001
    DAVENPORT, Maurice Hopwood
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    Diretor
    Pines
    Dormans Park
    RH19 2LX East Grinstead
    West Sussex
    United KingdomBritish6765160001
    DAVIS, Bryan Kenneth
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    Diretor
    75 Buckingham Avenue
    Toronto
    Ontario M4n 1r3
    Canada
    CanadaCanadian111671370001
    DONNE, David Lucas
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    Diretor
    8 Montague Mews North
    W1H 1AH London
    United KingdomBritish36527200001
    FAIRCHILD, Robert William
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Diretor
    26 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    BritainBritish16613760002
    FELL, Fraser Matthews
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Diretor
    34 Glenorchy Road
    M3C 2P9 Don Mills
    Ontario
    Canada
    Canadian36469670001
    FREUND, Michael Walter
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Diretor
    272 Belsize Drive
    M4S 1M6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469710001
    GAMBLE, Horace Roy
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    Diretor
    River Lodge 1 Ravensbury Drive
    TQ6 9BZ Dartmouth
    Devon
    British4379420001
    HARKER, William Clinton
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Diretor
    88 Hermitage Court
    Knighten Street
    E1 9PW London
    Canadian22380340003
    HOLBECHE, Philip Leslie
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    Diretor
    7 Milburn Walk
    KT18 5JN Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish7708940001
    JOLY, Laurent Maurice
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Diretor
    4 Berkeley Gardens
    Kensington
    W8 4AP London
    Canadian48827400001
    KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Diretor
    48-50 Cannon Street
    EC4N 6LD London
    Canadian36228770001
    KIMBALL, Marcus Richard, Lord
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    Diretor
    Great Easton Manor
    LE16 8TB Market Harborough
    Leicestershire
    British7708960001
    LAMBERT, Allen Thomas
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Diretor
    483 Russell Hill Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5p 2s8
    Canada
    Canadian7708970001
    LAURIE, Craig J
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Diretor
    The World Financial Center
    200 Vesey Street 11th Floor
    New York
    Ny 10281-1021
    Usa
    Canadian105152590003
    LOVEGROVE, Philip Albert
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    Diretor
    50 Thorley Lane
    Bishops Stortford
    CM23 4AD Hertfordshire
    British35568310001
    MACDOUGALL, Hartland Molson
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Diretor
    Belfountain
    FOREIGN Ontario L0n 1bo
    Canada
    Canadian7708980001
    MILLER, James William
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Diretor
    670 Fairmile Road
    V75 IR2 West Vancouver
    Bc
    Canada
    Canadian34028940001
    PORTER, Michael Andrew
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    Diretor
    Pitt Cottage
    Church Street Great Baddow
    CM2 7AA Chelmsford
    Essex
    British32404350001
    STROYAN, Colin Strathearn Ropner
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    Diretor
    Bridgend Of Teith
    FK16 6AD Doune
    Perthshire
    United KingdomBritish1866210001
    WALKER, James Barrett
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Diretor
    53 Hillhurst Boulevard
    M5N 1N5 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian36469780001
    ONTARIO LIMITED
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    Diretor
    Suite 1400
    70 York Street
    Toronto
    Ontario M5j 1sj
    Canada
    48719890001
    SURREY INVESTMENTS INCORPORATED
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Diretor
    Box 30616 Smb
    Genesis Building Genesis Close
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    68083360002

    Quem são as pessoas com controle significativo de GENTRA LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Gentra Holdings Company
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    19/04/2016
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Joanna Scott, Level 15, Citypoint
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroRegistrar Of Companies (England And Wales
    Número de registro02022747
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GENTRA LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Assignment
    Criado em 11/11/1994
    Entregue em 21/11/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 21/11/1994Registro de uma garantia (395)
    • 30/03/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment
    Criado em 21/07/1994
    Entregue em 29/07/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed)
    Breve descrição
    The sum of £952,500 in account no 31538268.
    Pessoas com direito
    • Guardian Assurance PLC
    Transações
    • 29/07/1994Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over cash
    Criado em 13/04/1994
    Entregue em 14/04/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge
    Breve descrição
    Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank of Canada (Iom) Limited
    Transações
    • 14/04/1994Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security agreement
    Criado em 09/03/1994
    Entregue em 24/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement
    Breve descrição
    All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transações
    • 24/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 31/01/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage sale agreement
    Criado em 29/07/1993
    Entregue em 05/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined)
    Breve descrição
    The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account.
    Pessoas com direito
    • Birmingham Midshires Mortgage Asset No.1 Limited
    Transações
    • 05/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/06/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 18/06/1993
    Entregue em 05/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transações
    • 05/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental security document
    Criado em 04/06/1993
    Entregue em 22/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein)
    Breve descrição
    By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transações
    • 22/06/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 17/05/1993
    Entregue em 07/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993.
    Breve descrição
    The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transações
    • 07/06/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 07/05/1993
    Entregue em 26/05/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993.
    Breve descrição
    The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trustco Limited.
    Transações
    • 26/05/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 23/04/1993
    Entregue em 10/05/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trustco Limited
    Transações
    • 10/05/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 22/04/1993
    Entregue em 29/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined)
    Breve descrição
    All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transações
    • 29/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Letter of amendment
    Criado em 14/04/1993
    Entregue em 29/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined)
    Breve descrição
    All present and future rights......see form 395.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transações
    • 29/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 07/04/1993
    Entregue em 22/04/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Switzerland)
    Transações
    • 22/04/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Security document
    Criado em 12/03/1993
    Entregue em 26/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Caribbean) Corporation
    Transações
    • 26/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 28/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 27/03/1986
    Entregue em 04/04/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details).
    Pessoas com direito
    • Royal Trust Bank (Jersey) Limited
    Transações
    • 04/04/1986Registro de uma garantia
    • 31/01/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0