ENVOPAK GROUP

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaENVOPAK GROUP
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada de responsabilidade ilimitada
    Número da empresa 00596706
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ENVOPAK GROUP?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica ENVOPAK GROUP?

    Endereço do escritório registrado
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ENVOPAK GROUP?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ENVOPAK LIMITED08/01/195808/01/1958

    Quais são as últimas contas de ENVOPAK GROUP?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para ENVOPAK GROUP?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    3 páginasAA

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/11/2011 para 31/12/2011

    1 páginasAA01

    Declaração anual preparada até 05/11/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital30/11/2011

    Estado do capital em 30/11/2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/11/2010

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/11/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/11/2009

    3 páginasAA

    Declaração anual preparada até 05/11/2009 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Ola Tricia Aramita Barreto-Morley em 01/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Philip Matthew Deakin em 01/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Edward Ufland em 01/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Giles Hudson em 01/10/2009

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para S & J Registrars Limited em 01/10/2009

    2 páginasCH04

    Término da nomeação de Gavin Udall como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Ola Tricia Aramita Barreto-Morley como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Philip Matthew Deakin como diretor

    2 páginasAP01

    Contas preparadas até 30/11/2008

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 30/11/2007

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas preparadas até 30/11/2006

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    Quem são os diretores de ENVOPAK GROUP?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Secretário
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Diretor
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Diretor
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Diretor
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Diretor
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Secretário
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Secretário
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Secretário
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    WICKETT, Edna May
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    Secretário
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    British36891520001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Secretário
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001
    ARTHUR, Frank Henry
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    Diretor
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish8141130001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Diretor
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Diretor
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Diretor
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    CAMERON, Ian Donald
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    Diretor
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    British13521010001
    HENSHAW, Robert Charles Mayon
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    Diretor
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    British66661330001
    HOLLINGSWORTH, Roger Colin
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    Diretor
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    British20963700001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Diretor
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    Diretor
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritish221394890001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    Diretor
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    British65122490001
    O'DOHERTY, Jean Crichton
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    Diretor
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglandBritish13964410001
    PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    Diretor
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    EnglandBritish5324930001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Diretor
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    REED, Peter John
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Diretor
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British21740620001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UDELHOFEN, Mark James
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    Diretor
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    American84364350001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Diretor
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    ENVOPAK GROUP possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 13/11/2000
    Entregue em 16/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 16/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 22/07/1998
    Entregue em 25/07/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 25/07/1998Registro de uma garantia (395)
    • 27/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 30/06/1995
    Entregue em 06/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 06/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 16/07/1998Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 27/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 02/03/1993
    Entregue em 06/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 09/02/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 31/03/1987
    Entregue em 03/04/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 03/04/1987Registro de uma garantia
    • 08/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 16/03/1987
    Entregue em 20/03/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 20/03/1987Registro de uma garantia
    • 08/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 29/09/1986
    Entregue em 20/10/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 20/10/1986Registro de uma garantia
    • 14/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 14/07/1970
    Entregue em 29/07/1970
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD.
    Breve descrição
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details).
    Pessoas com direito
    • The Charente Steamship Co LTD
    Transações
    • 29/07/1970Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 14/06/1968
    Entregue em 28/06/1968
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 28/06/1968Registro de uma garantia
    • 08/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Single debenture
    Criado em 06/01/1965
    Entregue em 07/01/1965
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc
    Breve descrição
    Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 07/01/1965Registro de uma garantia
    • 08/12/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0