G LIGHTFOOT & SON LIMITED

G LIGHTFOOT & SON LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaG LIGHTFOOT & SON LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00626296
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2022

    Quais são as últimas submissões para G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2022

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2021

    7 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2020

    6 páginasAA

    Nomeação de Miss Katherine Rebecca Jacob como diretor em 29/01/2021

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Lynette Gillian Krige como diretor em 29/01/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2019

    8 páginasAA

    Nomeação de Mrs Lynette Gillian Krige como diretor em 30/09/2019

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Sebastian Hobbs como diretor em 30/09/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de John Branson Nuttall como diretor em 01/10/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Thomas Richard John Ferguson como secretário em 26/04/2019

    2 páginasAP03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2018

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2017

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP England para C/O Tlt Llp Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ

    1 páginasAD02

    Término da nomeação de Anthony John Smith como diretor em 19/07/2017

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FERGUSON, Thomas Richard John
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Secretário
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    257914260001
    HOBBS, Sebastian
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Diretor
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritishChief Executive Officer262813420001
    JACOB, Katherine Rebecca
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Diretor
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer223624510001
    ASPDEN, Jeremy Broughton
    Crookfoot
    Crook
    LA8 8LW Kendal
    Cumbria
    Secretário
    Crookfoot
    Crook
    LA8 8LW Kendal
    Cumbria
    BritishPharmacist42384030001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secretário
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secretário
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    EnglishCompany Secretary43686960001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150535560001
    ASPDEN, Jeremy Broughton
    Crookfoot
    Crook
    LA8 8LW Kendal
    Cumbria
    Diretor
    Crookfoot
    Crook
    LA8 8LW Kendal
    Cumbria
    EnglandBritishPharmacist42384030001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Diretor
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Logistics140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Diretor
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishFinancial Controller49108820004
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Diretor
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritishHead Of Commercial125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Diretor
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglishCompany Secretary43686960001
    KRIGE, Lynette Gillian
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Diretor
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritishChief Finance Officer283338100002
    LATES, Christopher
    12 Esk Road
    CA3 0HN Carlisle
    Cumbria
    Diretor
    12 Esk Road
    CA3 0HN Carlisle
    Cumbria
    BritishPharmacist13670900001
    LIGHTFOOT, Maurice
    The Larches
    Wetheral
    CA4 8JY Carlisle
    Cumbria
    Diretor
    The Larches
    Wetheral
    CA4 8JY Carlisle
    Cumbria
    BritishPharmacist33289410001
    MARGERISON, Nigel Hill
    Holmecroft Park Road
    Scotby
    CA4 8AR Carlisle
    Cumbria
    Diretor
    Holmecroft Park Road
    Scotby
    CA4 8AR Carlisle
    Cumbria
    BritishPharmacist13670940001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Diretor
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive87486470001
    NUTTALL, John Branson
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Diretor
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    United KingdomBritishGeneral Manager195408270001
    RICHMAN, Jonathan Max
    17 Ravensway
    Prestwich
    M25 0EU Manchester
    Diretor
    17 Ravensway
    Prestwich
    M25 0EU Manchester
    EnglandBritishPharmacist54694490001
    RIGG, Robert David
    54 Scotby Road
    Scotby
    CA4 8BD Carlisle
    Cumbria
    Diretor
    54 Scotby Road
    Scotby
    CA4 8BD Carlisle
    Cumbria
    BritishPharmacist13670910002
    SMITH, Anthony John
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Diretor
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritishFinance Director - Healthcare137558680001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Office60114700001
    WESTERN, George Ernest
    Elm House
    Blackford
    CA6 4EA Carlisle
    Cumbria
    Diretor
    Elm House
    Blackford
    CA6 4EA Carlisle
    Cumbria
    BritishPharmacist13670920001

    Quem são as pessoas com controle significativo de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Bestway Panacea Healthcare Limited
    Castle Street
    Castlefield
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    06/04/2016
    Castle Street
    Castlefield
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland And Wales Company Register
    Número de registro09225514
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    G LIGHTFOOT & SON LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/2004
    Entregue em 28/07/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Yorkshire Bank
    Transações
    • 28/07/2004Registro de uma garantia (395)
    • 02/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 10/07/1995
    Entregue em 22/07/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    37 high street wigton cumbria and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/07/1995Registro de uma garantia (395)
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 15/01/1990
    Entregue em 19/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & buildings 25 main street keswick allerdale cumbria land at rear 25 main street aforsaid fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 19/01/1990Registro de uma garantia
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Standard security registered in scotland on the 15TH july 1985.
    Criado em 07/05/1985
    Entregue em 23/07/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and whole that chemist's shop in annan road, gretna, together with dwelling lane k/a 50, annan road, gretna, county of dumfries.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 23/07/1985Registro de uma garantia
    • 10/02/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 10/04/1985
    Entregue em 23/04/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & buildings known as 14 king street wigton allerdale cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 23/04/1985Registro de uma garantia
    • 10/12/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 15/06/1984
    Entregue em 23/06/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    3 and 5 london rd carlisle cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transações
    • 23/06/1984Registro de uma garantia
    • 21/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 16/03/1982
    Entregue em 24/03/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Plot of f/h land together with the buildings known as 8 middlegate penrith cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transações
    • 24/03/1982Registro de uma garantia
    • 21/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 19/08/1981
    Entregue em 03/09/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Plot of l/h land together with buildings erected at 140 botchergate carlisle cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transações
    • 03/09/1981Registro de uma garantia
    Deed
    Criado em 19/06/1981
    Entregue em 26/06/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to williams & glyns bank limited supplemental to a debenture dated 27 dec 63
    Breve descrição
    Fixed charge on all book debts & other debts of the company.
    Pessoas com direito
    • Mosley Street Nominees Limited
    Transações
    • 26/06/1981Registro de uma garantia
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 03/12/1974
    Entregue em 13/12/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    16, scotland road, stanwix, carlisle, cumbria tog with all fixtures.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transações
    • 13/12/1974Registro de uma garantia
    • 15/04/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 25/01/1971
    Entregue em 10/02/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Lease dated 2ND november 70 for ten years from 1ST nov 1970 at an annual rent of £600 of the two storied chemists shop 140 botchergate carlisle including all fixtures, plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transações
    • 10/02/1971Registro de uma garantia
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 20/07/1967
    Entregue em 26/07/1967
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to williams deacons bank LTD on any account whatsoever secured by a charge dated 27/12/63 on any account whatsoever.
    Breve descrição
    L/H shop occupying the ground floor and two basement rooms of 37,39 bank street carlisle.
    Pessoas com direito
    • Mosley Street Nominees LTD
    Transações
    • 26/07/1967Registro de uma garantia
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 30/10/1964
    Entregue em 09/11/1964
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Further securing all monies due from the company to williams deacons bank LTD secured by a debenture dated 27TH december 1968.
    Breve descrição
    55 wigton rd carlisle.
    Pessoas com direito
    • Mosley St Nominees LTD
    Transações
    • 09/11/1964Registro de uma garantia
    • 21/10/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 27/12/1963
    Entregue em 03/01/1964
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due etc to williams deacons bank LTD
    Breve descrição
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital (see doc 14 for other details).
    Pessoas com direito
    • Mosley Street Nominees
    Transações
    • 03/01/1964Registro de uma garantia
    • 13/10/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0