G LIGHTFOOT & SON LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | G LIGHTFOOT & SON LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00626296 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
Endereço do escritório registrado | c/o WELL Merchants Warehouse Castle Street M3 4LZ Manchester England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 30/06/2022 |
Quais são as últimas submissões para G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2022 | 7 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2020 | 6 páginas | AA | ||
Nomeação de Miss Katherine Rebecca Jacob como diretor em 29/01/2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Lynette Gillian Krige como diretor em 29/01/2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2019 | 8 páginas | AA | ||
Nomeação de Mrs Lynette Gillian Krige como diretor em 30/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Sebastian Hobbs como diretor em 30/09/2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de John Branson Nuttall como diretor em 01/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Nomeação de Mr Thomas Richard John Ferguson como secretário em 26/04/2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2017 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP England para C/O Tlt Llp Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ | 1 páginas | AD02 | ||
Término da nomeação de Anthony John Smith como diretor em 19/07/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Quem são os diretores de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGUSON, Thomas Richard John | Secretário | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | 257914260001 | |||||||
HOBBS, Sebastian | Diretor | Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | Chief Executive Officer | 262813420001 | ||||
JACOB, Katherine Rebecca | Diretor | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | Chief Financial Officer | 223624510001 | ||||
ASPDEN, Jeremy Broughton | Secretário | Crookfoot Crook LA8 8LW Kendal Cumbria | British | Pharmacist | 42384030001 | |||||
ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Secretário | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||
JONES, Philip Robert | Secretário | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | Company Secretary | 43686960001 | |||||
SELLERS, Caroline Jane | Secretário | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 150535560001 | |||||||
ASPDEN, Jeremy Broughton | Diretor | Crookfoot Crook LA8 8LW Kendal Cumbria | England | British | Pharmacist | 42384030001 | ||||
BATTY, Peter David | Diretor | Church Hill Ingham LN1 2YE Lincoln 2 Lincolnshire United Kingdom | England | British | Head Of Logistics | 140380300001 | ||||
BROCKLEHURST, Jonathan David | Diretor | Larch House 29 Keele Road ST5 2JT Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | Financial Controller | 49108820004 | |||||
FARQUHAR, Gordon Hillocks | Diretor | 3 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull | United Kingdom | British | Head Of Commercial | 125645380001 | ||||
JONES, Philip Robert | Diretor | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | United Kingdom | English | Company Secretary | 43686960001 | ||||
KRIGE, Lynette Gillian | Diretor | Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | Chief Finance Officer | 283338100002 | ||||
LATES, Christopher | Diretor | 12 Esk Road CA3 0HN Carlisle Cumbria | British | Pharmacist | 13670900001 | |||||
LIGHTFOOT, Maurice | Diretor | The Larches Wetheral CA4 8JY Carlisle Cumbria | British | Pharmacist | 33289410001 | |||||
MARGERISON, Nigel Hill | Diretor | Holmecroft Park Road Scotby CA4 8AR Carlisle Cumbria | British | Pharmacist | 13670940001 | |||||
MARKS, Peter Vincent | Diretor | The Old Barn Low House Farm Otley Road Eldwick BD16 3AZ Bingley West Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 87486470001 | ||||
NUTTALL, John Branson | Diretor | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | United Kingdom | British | General Manager | 195408270001 | ||||
RICHMAN, Jonathan Max | Diretor | 17 Ravensway Prestwich M25 0EU Manchester | England | British | Pharmacist | 54694490001 | ||||
RIGG, Robert David | Diretor | 54 Scotby Road Scotby CA4 8BD Carlisle Cumbria | British | Pharmacist | 13670910002 | |||||
SMITH, Anthony John | Diretor | c/o Well Castle Street M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | England | British | Finance Director - Healthcare | 137558680001 | ||||
WATES, Martyn James | Diretor | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Chief Financial Office | 60114700001 | ||||
WESTERN, George Ernest | Diretor | Elm House Blackford CA6 4EA Carlisle Cumbria | British | Pharmacist | 13670920001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de G LIGHTFOOT & SON LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestway Panacea Healthcare Limited | 06/04/2016 | Castle Street Castlefield M3 4LZ Manchester Merchants Warehouse England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
G LIGHTFOOT & SON LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Criado em 26/07/2004 Entregue em 28/07/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 10/07/1995 Entregue em 22/07/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 37 high street wigton cumbria and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/01/1990 Entregue em 19/01/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land & buildings 25 main street keswick allerdale cumbria land at rear 25 main street aforsaid fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Standard security registered in scotland on the 15TH july 1985. | Criado em 07/05/1985 Entregue em 23/07/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All and whole that chemist's shop in annan road, gretna, together with dwelling lane k/a 50, annan road, gretna, county of dumfries. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 10/04/1985 Entregue em 23/04/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land & buildings known as 14 king street wigton allerdale cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 15/06/1984 Entregue em 23/06/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 3 and 5 london rd carlisle cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 16/03/1982 Entregue em 24/03/1982 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Plot of f/h land together with the buildings known as 8 middlegate penrith cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 19/08/1981 Entregue em 03/09/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Plot of l/h land together with buildings erected at 140 botchergate carlisle cumbria together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed | Criado em 19/06/1981 Entregue em 26/06/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to williams & glyns bank limited supplemental to a debenture dated 27 dec 63 | |
Breve descrição Fixed charge on all book debts & other debts of the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 03/12/1974 Entregue em 13/12/1974 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 16, scotland road, stanwix, carlisle, cumbria tog with all fixtures. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 25/01/1971 Entregue em 10/02/1971 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Lease dated 2ND november 70 for ten years from 1ST nov 1970 at an annual rent of £600 of the two storied chemists shop 140 botchergate carlisle including all fixtures, plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 20/07/1967 Entregue em 26/07/1967 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to williams deacons bank LTD on any account whatsoever secured by a charge dated 27/12/63 on any account whatsoever. | |
Breve descrição L/H shop occupying the ground floor and two basement rooms of 37,39 bank street carlisle. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage | Criado em 30/10/1964 Entregue em 09/11/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Further securing all monies due from the company to williams deacons bank LTD secured by a debenture dated 27TH december 1968. | |
Breve descrição 55 wigton rd carlisle. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 27/12/1963 Entregue em 03/01/1964 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due etc to williams deacons bank LTD | |
Breve descrição Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital (see doc 14 for other details). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0