HMV CARD SERVICES LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | HMV CARD SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00635858 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de HMV CARD SERVICES LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Windsor House Spittal Street SL7 3HJ Marlow Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| HMV SHOPS LIMITED | 12/05/1986 | 12/05/1986 |
| RADIO RENTALS THAMESDOWN CABLE LIMITED | 17/06/1983 | 17/06/1983 |
| CLEARVISION,LIMITED | 27/08/1959 | 27/08/1959 |
Quais são as últimas contas de HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 28/04/2012 |
Quais são as últimas submissões para HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Término da nomeação de Ian Peter Kenyon como diretor em 31/01/2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Trevor Philip Moore como diretor em 08/02/2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Elaine Marriner como diretor em 24/01/2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Elaine Marriner como secretário em 24/01/2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ian Peter Kenyon como diretor em 03/09/2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Trevor Philip Moore como diretor em 03/09/2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Simon Richard Fox como diretor em 03/09/2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/04/2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 10/05/2012 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR em 13/03/2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 10/05/2011 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Neil Bright como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 24/04/2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 10/05/2010 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Elaine Marriner em 10/05/2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Richard Fox em 10/05/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Elaine Marriner em 10/05/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Neil Irvine Bright em 10/05/2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 13 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 25/04/2009 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
Quem são os diretores de HMV CARD SERVICES LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT, Neil Irvine | Secretário | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | British | 180993450001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Secretário | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Secretário | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Secretário | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | British | 76768320001 | ||||||
| MARRINER, Elaine | Secretário | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | British | 40470020001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Secretário | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SMITH, George Marsden | Secretário | 18 Bevin Square SW17 7BB London | British | 15729150003 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Secretário | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63502600001 | ||||||
| BELL, Duncan Charles | Diretor | Longwood Queen Annes Road SL4 2BJ Windsor Berkshire | British | 9950440002 | ||||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Diretor | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| FOX, Simon Richard | Diretor | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||
| GILES, Alan James | Diretor | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Diretor | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| KENYON, Ian Peter | Diretor | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 107735600001 | |||||
| LYMATH, Michael Gerald | Diretor | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| MARRINER, Elaine | Diretor | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 40470020001 | |||||
| MCALLISTER, Stuart | Diretor | The Granary 38 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 9406880001 | ||||||
| MOORE, Trevor Philip | Diretor | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 113047410001 | |||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Diretor | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 63502600001 |
HMV CARD SERVICES LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 22/05/1998 Entregue em 04/06/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998) | Criado em 14/05/1998 Entregue em 15/05/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 28/03/1998 Entregue em 09/04/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 28/03/1998 Entregue em 09/04/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Breve descrição By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0