CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED

CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCHEMICAL INNOVATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00637686
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    • fabricação de outros produtos químicos n.e.c. (20590) / Indústrias transformadoras

    Onde fica CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    217 Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    Lancashire
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    COMPOUNDING INGREDIENTS LIMITED 23/09/195923/09/1959

    Quais são as últimas contas de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2020

    Quais são as últimas submissões para CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 27/08/2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 02/08/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2020

    7 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ England para 217 Walton Summit Road Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ em 29/04/2021

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de 27 Riverside Way Uxbridge Middlesex UB8 2YF para PO Box PR5 8AQ 271 Walton Summit Walton Summit Rod Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8AQ em 27/04/2021

    1 páginasAD01

    Nomeação de Citco Management Uk Ltd como secretário em 28/06/2019

    2 páginasAP04

    Declaração de confirmação apresentada em 07/08/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2019

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Bernd Paul Josef Helfrich como diretor em 30/04/2019

    1 páginasTM01

    Retirada de uma declaração de pessoa com controlo significativo em 13/11/2019

    2 páginasPSC09

    Declaração de confirmação apresentada em 07/08/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2018

    14 páginasAA

    Término da nomeação de Birgitt Michaela Nord como secretário em 29/03/2019

    1 páginasTM02

    Declaração de confirmação apresentada em 07/08/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Charles Richard Spalton como diretor em 30/04/2018

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2017

    14 páginasAA

    Nomeação de Heidi Ann Weiler como diretor em 20/10/2017

    3 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2016

    24 páginasAA

    Quem são os diretores de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CITCO MANAGEMENT UK LTD
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7
    United Kingdom
    Secretário
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro02656801
    252274080001
    HECKMANN, Gert Gunter Werner, Dr
    Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    217
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    Walton Summit Road
    Bamber Bridge
    PR5 8AQ Preston
    217
    Lancashire
    United Kingdom
    GermanyGerman197800590001
    WEILER, Heidi Ann, Ms.
    Willow Lake Boulevard
    P.O. Box 64683
    St Paul
    1200
    Minnesota 55164-0683
    United States
    Diretor
    Willow Lake Boulevard
    P.O. Box 64683
    St Paul
    1200
    Minnesota 55164-0683
    United States
    United StatesAmerican239047270001
    ASTLES, Peter Blair
    165 Shaftsbury Avenue
    Timperley
    WA15 7AY Altrincham
    Cheshire
    Secretário
    165 Shaftsbury Avenue
    Timperley
    WA15 7AY Altrincham
    Cheshire
    British14727110001
    NORD, Birgitt Michaela
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Secretário
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    221512510001
    SMART, Iain
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    Secretário
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    British30605140001
    STIRZAKER, Mark Robert
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    Secretário
    Lower Dunishbooth House
    Lane Head
    OL12 6BH Rochdale
    Lancashire
    British78366970002
    VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Secretário
    Middleton
    M24 2DB Manchester
    Oldham Road
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro01031815
    110906090002
    ASH, Arthur Burr
    292 Roosevelt Place
    Grosse Pointe Michigan 48230
    FOREIGN
    Usa
    Diretor
    292 Roosevelt Place
    Grosse Pointe Michigan 48230
    FOREIGN
    Usa
    Usa14727120001
    ASTLES, Peter Blair
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish14727110003
    ASTLES, Peter Blair
    94 Stockport Road
    Timperley
    WA15 7SN Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    94 Stockport Road
    Timperley
    WA15 7SN Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish14727110003
    BENAROUS, Aissa
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    UkBritish114284480001
    BENAROUS, Aissa
    11a Trafalgar Road
    Birkdale
    PR2 8EA Southport
    Merseyside
    Diretor
    11a Trafalgar Road
    Birkdale
    PR2 8EA Southport
    Merseyside
    British60210410001
    BURLEY, Nicholas James
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    Diretor
    45 Pall Mall
    SW1Y 5JG London
    Times Place
    United KingdomBritish122799590001
    CAPPS, Samuel Henderson
    47 Daily Hills Circle
    Ringgold Georgia 30736
    FOREIGN
    Usa
    Diretor
    47 Daily Hills Circle
    Ringgold Georgia 30736
    FOREIGN
    Usa
    Usa14727140001
    COX, Stephen John
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    EnglandBritish16542850004
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    Diretor
    Belvedere Lodge
    18 Highbury Road Wimbledon Village
    SW19 7PR London
    EnglandBritish105961550001
    GOMBERG, Edward Nicholas
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    37406 Tennessee
    Usa
    Diretor
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    37406 Tennessee
    Usa
    Usa14727150004
    GOMBERG, Helen Elizabeth
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    FOREIGN Tennessee 37406 Usa
    Diretor
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    FOREIGN Tennessee 37406 Usa
    American41936190002
    GOMBERG, Jeffrey Gregory
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    Tennessee 37406
    Usa
    Diretor
    2003 Amnicola Highway
    Chattanooga
    Tennessee 37406
    Usa
    American30605130003
    HARRIS, Howard Elliott
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    Diretor
    15 Queen's Gate Gardens
    SW7 5LY London
    British93378750001
    HAY, Nigel Bruce
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish124316170001
    HAY, Nigel Bruce
    The New Shippen
    Higher Lane Scorton
    PR3 1BE Preston
    Lancashire
    Diretor
    The New Shippen
    Higher Lane Scorton
    PR3 1BE Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish124316170001
    HELFRICH, Bernd Paul Josef
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    GermanyGerman197801580001
    MARTIN, Robert Stephen
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish150864050001
    MAUNDRELL, Graham Lloyd
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish56093930002
    MELTHAM, John David
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish74570910001
    MENENDEZ, Joseph Henry
    32 Iverna Gardens
    W8 6TW London
    Diretor
    32 Iverna Gardens
    W8 6TW London
    UsaAmerican127225800001
    MILLER, Matthew Kerr
    Hollins Lane
    SK6 5DA Marple Bridge
    106
    Cheshire
    Diretor
    Hollins Lane
    SK6 5DA Marple Bridge
    106
    Cheshire
    United KingdomBritish179720330001
    O'CONNOR, Calvin James John
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    10 Moss Lane
    Timperley
    WA15 6SZ Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16253240001
    OLIVER, John Lancaster
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    Diretor
    The Croft House
    4 Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    United KingdomUnited Kingdom116941050001
    SIMMONDS, Barrie
    60 Fairlands Road
    BL9 6QB Bury
    Greater Manchester
    Diretor
    60 Fairlands Road
    BL9 6QB Bury
    Greater Manchester
    British60210430001
    SMART, Iain
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    Diretor
    132a Roe Lane
    PR9 7PJ Southport
    Merseyside
    British30605140001
    SPALTON, Charles Richard
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    Diretor
    Riverside Way
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    Middlesex
    United KingdomBritish1786610001
    WEXLER, Eric Monroe
    523 Fern Trail
    Signal Mountain
    Tennessee 37377-3168
    Usa
    Diretor
    523 Fern Trail
    Signal Mountain
    Tennessee 37377-3168
    Usa
    American30605120003

    Quem são as pessoas com controle significativo de CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Kommerling Uk Ltd
    Riverside Way
    Cowley
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    England
    06/04/2016
    Riverside Way
    Cowley
    UB8 2YF Uxbridge
    27
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House London
    Número de registro04028071
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    08/08/201613/11/2019A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que existe uma pessoa registável em relação à empresa, mas não a identificou.

    CHEMICAL INNOVATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 01/10/2013
    Entregue em 09/10/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transações
    • 09/10/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 27/08/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 01/10/2013
    Entregue em 04/10/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ge Factofrance S.A.S.
    Transações
    • 04/10/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 27/08/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 23/04/2009
    Entregue em 01/05/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent
    Transações
    • 01/05/2009Registro de uma garantia (395)
    • 30/09/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 07/12/2007
    Entregue em 21/12/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Trustee for the Secured Parties)
    Transações
    • 21/12/2007Registro de uma garantia (395)
    • 20/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/08/2005
    Entregue em 12/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transações
    • 12/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/05/2007Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 20/05/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/03/2003
    Entregue em 28/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 15/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/03/2003
    Entregue em 28/03/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of legal mortgage the f/h property known as 217 walton summit road, walton summit centre, bamber bridge, preston, lancashire, PR5 8AQ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/03/2003Registro de uma garantia (395)
    • 15/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/11/1982
    Entregue em 09/12/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H unit 217, walton summit centre, bamber bridge. Preston, lancashire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/12/1982Registro de uma garantia
    • 22/03/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge on a building agreement
    Criado em 06/04/1979
    Entregue em 24/04/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the interest of the company in a building agreement 10.1.79 between central lancashire new town development corporation & the company relating to unit 217, walton summit centre, bomlier bridge, preston, lancashire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 24/04/1979Registro de uma garantia
    • 22/03/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 16/12/1974
    Entregue em 24/12/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land & bldg. On the northeast side of dearding st, greater manchester.
    Pessoas com direito
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transações
    • 24/12/1974Registro de uma garantia
    • 22/03/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 09/08/1974
    Entregue em 20/08/1974
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    581 lytham road, blackpool. Lancs, together with land forming the site & appointment thereto.
    Pessoas com direito
    • Bank of America National Trust & Savings Association
    Transações
    • 20/08/1974Registro de uma garantia
    • 22/03/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0