ITV BORDER LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ITV BORDER LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00654206 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ITV BORDER LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica ITV BORDER LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Itv White City 201 Wood Lane W12 7RU London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ITV BORDER LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| BORDER TELEVISION LIMITED | 28/03/1960 | 28/03/1960 |
Quais são as últimas contas de ITV BORDER LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para ITV BORDER LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Itv Broadcasting Limited como pessoa com controlo significativo em 24/05/2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2022 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE United Kingdom para Itv White City 201 Wood Lane London W12 7RU em 23/05/2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2021 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2020 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Término da nomeação de Helen Jane Tautz como diretor em 11/04/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de The London Television Centre Upper Ground London SE1 9LT United Kingdom para 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE em 06/06/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/08/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/08/2015 com lista completa de acionistas | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/08/2014 com lista completa de acionistas | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de ITV BORDER LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRVING, Eleanor Kate | Diretor | 201 Wood Lane W12 7RU London Itv White City United Kingdom | United Kingdom | British | 185037250001 | |||||
| BROWNLOW, Peter | Secretário | Quarry Bank Capon Hill CA8 1QN Brampton Cumbria | British | 4459070001 | ||||||
| CUSICK, Nicholas Jonathan Paul | Secretário | 30 Longlands Road CA3 9AD Carlisle | British | 50942120001 | ||||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Secretário | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| SCHWARZ, Nathalie Esther | Secretário | Flat 10 28 Belsize Avenue NW3 4AU London | British | 59245010001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Secretário | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | British | 37564540001 | ||||||
| ALLEN, Charles Lamb | Diretor | 70 Woodsford Square W14 8DS London | British | 63372790009 | ||||||
| BRADFORD, Rachel Julia | Diretor | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 175119720002 | |||||
| BRAGG, Melvyn, Lord | Diretor | 12 Hampstead Hill Gardens NW3 2PL London | United Kingdom | British | 21737580001 | |||||
| BROWNLOW, Peter | Diretor | Quarry Bank Capon Hill CA8 1QN Brampton Cumbria | British | 4459070001 | ||||||
| BURGESS, (Robin) Robert Lawie Frederick | Diretor | Hall Flatt Scaleby CA6 4LE Carlisle Cumbria | British | 21402620001 | ||||||
| BURKETT, Mary Elizabeth | Diretor | Isel Hall CA13 Cockermouth Cumbria | British | 21402630001 | ||||||
| BUTTERFIELD, Stewart David | Diretor | 26 Gerrard Road N1 8AY London | British | 54977570001 | ||||||
| CANETTY CLARKE, Neil Ashley | Diretor | Horsebrooks Farm Williards Will TN19 7DB Etchingham East Sussex | United Kingdom | British | 85247640001 | |||||
| CORLEY, Paul John | Diretor | Holly House Langley Gardens Corby Hill CA4 8PS Carlisle | British | 61633470001 | ||||||
| CROFT, David Michael Bruce | Diretor | Shamrock Cottage Foxcovert Lane WA16 9QP Knutsford Cheshire | England | British | 56897060002 | |||||
| CUSICK, Nicholas Jonathan Paul | Diretor | 30 Longlands Road CA3 9AD Carlisle | British | 50942120001 | ||||||
| DAVIES, Paul Richard | Diretor | 4 Park Avenue East Sheen SW14 8AT London | British | 55332120001 | ||||||
| DESMOND, Michael John | Diretor | 5 Copse Hill Wimbledon SW20 0NB London | England | British | 31522290002 | |||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Diretor | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Diretor | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| GRAHAM, James Lowery | Diretor | Oak House Great Corby CA4 8NE Carlisle Cumbria | British | 2014530001 | ||||||
| GREEN, Michael Anthony | Diretor | 70 Spurgate Hutton Mount CM13 2JT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 33864440003 | |||||
| GREEN, Michael Anthony | Diretor | 70 Spurgate Hutton Mount CM13 2JT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 33864440003 | |||||
| HARRIS, Peter Jonathan | Diretor | 381 Wimbledon Park Road SW19 6PE London | England | British | 40917640001 | |||||
| HARTLEY, Malcolm Brian | Diretor | Westville Tynwald Road ISLE MAN Peel Isle Of Man | British | 23124240001 | ||||||
| IRVING, Eleanor Kate | Diretor | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| IRVING, Eleanor Kate | Diretor | Plimsoll Road N4 2ED London 137 | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| JONES, Clive William | Diretor | 48 Church Crescent Muswell Hill N10 3NE London | England | British | 112692490001 | |||||
| MAXWELL STUART, Catherine Margaret Mary | Diretor | Traquair House EH44 6PW Innerleithen Peebleshire | Scotland | British | 1154500002 | |||||
| MCCULLOCH, Ian Douglas | Diretor | Mayfield Knipp Hill KT11 2PE Cobham Surrey | British | 72107570002 | ||||||
| MEDLICOTT, William Jonathan | Diretor | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | England | English | 44636500002 | |||||
| MERRALL, Douglas Edward | Diretor | The Green Irthington CA6 4NJ Brampton Cumbria | British | 72835090001 | ||||||
| PATERSON-BROWN, June, Dr. | Diretor | Norwood TD9 7HP Hawick Roxburghshire | British | 735690001 | ||||||
| QUINN, Andrew | Diretor | Kilnholme Penton CA6 5QZ Carlisle | British | 42394270002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ITV BORDER LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itv Broadcasting Limited | 06/04/2016 | 201 Wood Lane W12 7RU London Itv White City United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
ITV BORDER LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Criado em 31/03/1999 Entregue em 09/04/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição L/H property k/a land on the durranhill industrial estate carlisle also K.a the television centre durranhill brunel way carlisle cumbria. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 31/03/1999 Entregue em 09/04/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 25/03/1991 Entregue em 28/03/1991 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 29/12/1987 Entregue em 11/01/1988 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 18 clerkenwell close l/b of islington t/no ngl 217492 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 17/11/1987 Entregue em 03/12/1987 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição L/H property k/a land & buildings at durranhill industrial estate carlisle and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 13/04/1972 Entregue em 03/05/1972 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land on durranhill estate, carlisle. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0