KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED

KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00658852
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CHEMRING EOD LIMITED21/08/200821/08/2008
    SEGMATIC LIMITED11/05/196011/05/1960

    Quais são as últimas contas de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/10/2017

    Quais são as últimas submissões para KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 23/07/2019

    • Capital: GBP 1.10
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 08/07/2019
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2019 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2017

    7 páginasAA

    Término da nomeação de Michael James Flowers como diretor em 30/06/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2018 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2016

    8 páginasAA

    Nomeação de Mr Andrew Gregory Lewis como diretor em 19/01/2017

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/01/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Sarah Louise Ellard em 03/01/2017

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Steven John Bowers como diretor em 30/09/2016

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2015

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/01/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital27/01/2016

    Estado do capital em 27/01/2016

    • Capital: GBP 2,300
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2014

    8 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Michael James Flowers em 13/03/2015

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 01/01/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/01/2015

    Estado do capital em 02/01/2015

    • Capital: GBP 2,300
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Sarah Louise Ellard em 09/12/2014

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Sarah Louise Ellard em 09/12/2014

    1 páginasCH03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/10/2013

    8 páginasAA

    Nomeação de Mr Michael James Flowers como diretor em 24/07/2014

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Secretário
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    British43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Diretor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritish222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secretário
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secretário
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secretário
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Diretor
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    British18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1525670001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralian188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Diretor
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    British85421380001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Diretor
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    United KingdomBritish42841660001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Diretor
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    British25679470001
    MORRIS, Keith Hedley
    17 Hill Hayes Lane
    Hullavington
    SN14 6EB Chippenham
    Wiltshire
    Diretor
    17 Hill Hayes Lane
    Hullavington
    SN14 6EB Chippenham
    Wiltshire
    British6212480001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish45628680002
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Diretor
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Diretor
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish42825970001

    Quem são as pessoas com controle significativo de KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30/06/2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro2244623
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    KEMBREY CORPORATE TRUSTEE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge
    Criado em 11/10/1993
    Entregue em 13/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 18/12/89
    Breve descrição
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 13/10/1993Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 19/10/1990
    Entregue em 05/11/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of legal mortgage f/h land and buildings at pigeon house lane, stratton street, swindon, wiltshire. Title no. Wt 64373; and a fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transações
    • 05/11/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 29/09/1990
    Entregue em 09/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transações
    • 09/10/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/12/1989
    Entregue em 08/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from kembrey group limited and from the company under the terms of the charge to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    F/H land & buildings lying to north west of pigeon house lane stratton st margaret swindon wilts.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 08/01/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 18/12/1989
    Entregue em 02/01/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/01/1990Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 10/08/1988
    Entregue em 23/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from kembrey group limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge to the chargee
    Breve descrição
    Land at pigeon house lane, stratton st. Margaret, swindon, wiltshire.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 23/08/1988Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 15/07/1988
    Entregue em 21/07/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First fixed charge on all book and other debts. Floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 21/07/1988Registro de uma garantia
    • 15/03/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 24/02/1987
    Entregue em 05/03/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from kembrey industries limited or any of its subsidiaries. To the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Land at pigeon house lane, stratton, st.margaret, swindon, wiltshire and all other the f/h & l/h properties.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Caisse Nationale De Credit Argicole.
    Transações
    • 05/03/1987Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 18/11/1982
    Entregue em 30/11/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & factory premises at priory road kenilworth.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 30/11/1982Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 19/10/1982
    Entregue em 09/11/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over all book debts & other debts. Floating charge over (see doc. M55).. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 09/11/1982Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0