HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED

HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00726089
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HAYS BUSINESS SERVICES LTD15/11/198815/11/1988
    HAYS BUSINESS SERVICES LIMITED31/12/197931/12/1979
    HAY'S WHARF HAULAGE(S.W.)LIMITED04/06/196204/06/1962

    Quais são as últimas contas de HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2017

    Quais são as últimas submissões para HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    19 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2022

    17 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2021

    12 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Falecimento de um liquidatário

    3 páginasLIQ09

    Término da nomeação de Ian David Pratt como diretor em 19/10/2020

    1 páginasTM01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2020

    13 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 30/05/2019

    11 páginasLIQ03

    Declaração de confirmação apresentada em 05/10/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 250 Euston Road London NW1 2AF para 55 Baker Street London W1U 7EU em 25/06/2018

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 31/05/2018

    LRESSP

    Término da nomeação de Paul Venables como diretor em 14/05/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Douglas George Evans como diretor em 14/05/2018

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 09/01/2018

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 21/12/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 30/06/2017

    15 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 05/10/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    legacy

    5 páginasRP04CS01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 30/06/2016

    14 páginasAA

    Quem são os diretores de HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HAYS NOMINEES LIMITED
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Secretário
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro928949
    100317500002
    BAXTER, David Malcolm
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    Secretário
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    British18407470001
    BORT, Stefan Edward
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Secretário
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    British32824200011
    LAYTON, Robert
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    Secretário
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    British75448020002
    PRENTICE, Anthony Frank
    Abbey Wells Cottage
    Woolton Hill
    RG15 9UW Newbury
    Berkshire
    Secretário
    Abbey Wells Cottage
    Woolton Hill
    RG15 9UW Newbury
    Berkshire
    British29038600001
    REAY, Sally Jane
    34 Sedgmoor Road
    Flackwell Heath
    HP10 9AP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretário
    34 Sedgmoor Road
    Flackwell Heath
    HP10 9AP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British41603850002
    STOCK, John Patrick
    Belton 3a Highlands Road
    Heath End
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Secretário
    Belton 3a Highlands Road
    Heath End
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    British30640450001
    ALDRIDGE, Mark Ewart
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    Diretor
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    EnglandBritish66832950001
    BAXTER, David Malcolm
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    Diretor
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    British18407470001
    BERRY, Mark Ian James
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Diretor
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish96582270003
    BIDEN, Michael James
    St Giles Hilltop Northbrook Close
    SO23 0JR Winchester
    Hampshire
    Diretor
    St Giles Hilltop Northbrook Close
    SO23 0JR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish55905440001
    BROUGHAM, Peter David
    25 Limes Way
    Shabbington
    HP18 9HB Aylesbury
    Diretor
    25 Limes Way
    Shabbington
    HP18 9HB Aylesbury
    EnglandBritish114600540001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    Diretor
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    British95347040001
    CHARLTON, Keith Pearson
    The Coach House
    Duncote
    NN12 8AQ Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    The Coach House
    Duncote
    NN12 8AQ Towcester
    Northamptonshire
    British51102460005
    COLE, John Robert
    Dairy Farm Sutton Hoo
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Diretor
    Dairy Farm Sutton Hoo
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish49591410003
    DOBSON, Peter, Dr
    23 Beeches End
    Boston Spa
    LS23 6HL Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    23 Beeches End
    Boston Spa
    LS23 6HL Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish35270770001
    EVANS, Douglas George
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Diretor
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish78234950002
    FROST, Ronald Edwin
    Thorncombe Park Thorncombe Street
    Bramley
    GU5 0ND Guildford
    Surrey
    Diretor
    Thorncombe Park Thorncombe Street
    Bramley
    GU5 0ND Guildford
    Surrey
    British6339840002
    FULLER, Brian Leslie
    Cotswold House
    Hoo Lane
    GL55 6AZ Chipping Campden
    Gloucestershire
    Diretor
    Cotswold House
    Hoo Lane
    GL55 6AZ Chipping Campden
    Gloucestershire
    British36745670001
    GLEESON, Paul
    Foxhaunt House
    100 Saint Andrews Road
    RG9 1PL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Foxhaunt House
    100 Saint Andrews Road
    RG9 1PL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British69637020001
    GRAY, Simon
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Diretor
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    British106274260003
    HARRISON, Michael John
    16 Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    Northamptonshire
    Diretor
    16 Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    Northamptonshire
    British80215760001
    HEWITT, Trevor
    3 Stafford Close
    Lang Farm
    NN11 5GN Daventry
    Northamptonshire
    Diretor
    3 Stafford Close
    Lang Farm
    NN11 5GN Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritish75727820001
    HODGSON, John Gordon
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    Diretor
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    British65293600001
    LAWSON, Robert Arthur
    141 Moorgate
    EC2M 6TX London
    Diretor
    141 Moorgate
    EC2M 6TX London
    British9230610003
    LEWIS, Colin Ernest
    Willow Creek
    Mill Creek Court, Chertsey Road
    TW17 9LA Shepperton
    Middlesex
    Diretor
    Willow Creek
    Mill Creek Court, Chertsey Road
    TW17 9LA Shepperton
    Middlesex
    United KingdomBritish69553890001
    MARTIN, John Walley
    Locksley
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Diretor
    Locksley
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    British143523590001
    MATTHEWS, Colin Stephen
    Millmead
    GU2 4HJ Guildford
    Hays House
    Surrey
    Diretor
    Millmead
    GU2 4HJ Guildford
    Hays House
    Surrey
    United KingdomBritish55866900003
    MCLACHLAN, Neil Andrew
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish78366690001
    MORGAN, Robert James
    23 St Georges Road
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    23 St Georges Road
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    British60273420001
    MOUNSEY, Simon Charles Finch
    Barnes House
    Piltdown
    TN22 3XN Uckfield
    East Sussex
    Diretor
    Barnes House
    Piltdown
    TN22 3XN Uckfield
    East Sussex
    British18969920001
    NAPIER, John Alan
    Slough Farm House Slough Lane
    Headley
    KT18 6NZ Epsom
    Surrey
    Diretor
    Slough Farm House Slough Lane
    Headley
    KT18 6NZ Epsom
    Surrey
    British9716880003
    PRATT, Ian David
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    Diretor
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    EnglandBritish216303100001
    PRENTICE, Anthony Frank
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    Diretor
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    British65443130002
    RICHARDSON, David Gordon
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    Diretor
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    British50331150002

    Quem são as pessoas com controle significativo de HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    06/04/2016
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro93338
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 and
    Criado em 14/01/2008
    Entregue em 31/01/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 31/01/2008Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement)
    Criado em 18/02/2005
    Entregue em 10/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 10/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement)
    Criado em 17/10/2003
    Entregue em 22/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 22/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/07/2002
    Entregue em 05/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £4,000,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Borthwick wharf and land on the north east side of borthwick street and paynes wharf deptford london SE8 t/n TGL178058 and TGL178052.
    Pessoas com direito
    • George Wimpey Central London Limited
    Transações
    • 05/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 10/08/1989
    Entregue em 14/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 19TH nov, 1987.
    Breve descrição
    Land in levon road, title no 88586. land fronting bow greek river lee title no. 106593 land on the east side of leven road title no. 147899 all in the L.B. of tower hamlets.
    Pessoas com direito
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transações
    • 14/08/1989Registro de uma garantia
    Charge
    Criado em 31/07/1989
    Entregue em 07/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee for the banks under or by virtue of a guarantee and debenture dated 19/11/87
    Breve descrição
    F/H land & buildings on north side of derby street, manchester title no la 332096 f/h land k/a paynes wharf, deptford greenwich title no sgl 337627.
    Pessoas com direito
    • Barclays De Zoete Webb Limited
    Transações
    • 07/08/1989Registro de uma garantia
    Guarantee and composite trust debenture
    Criado em 19/11/1987
    Entregue em 24/11/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclays de zoete wedd limited as trustee under the terms of this guarantee and debenture and/or the overdraft letters of even date.
    Breve descrição
    (See doc M244/NOV25/ct for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays De Zoete Wedd Limitedas Trustee.
    Transações
    • 24/11/1987Registro de uma garantia
    Letter of set off
    Criado em 10/06/1983
    Entregue em 29/06/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descrição
    Any account of the company with lloyds bank PLC.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 29/06/1983Registro de uma garantia

    HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    31/05/2018Início da liquidação
    14/01/2023Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Edward Terence Kerr
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profissional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profissional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Profissional
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0