DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED

DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaDISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00733686
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DISPLAYMATICS LIMITED28/08/196228/08/1962

    Quais são as últimas contas de DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2021

    Quais são as últimas submissões para DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Zane Cedomir Mersich em 11/01/2022

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales para Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 páginasAD02

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    6 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Zane Cedomir Mersich em 22/09/2020

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales para Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB em 13/07/2020

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England para Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB em 16/03/2020

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Neil Paramore como secretário em 28/01/2020

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Neil Paramore como diretor em 28/01/2020

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Andrew Mark Glennon como secretário em 28/01/2020

    2 páginasAP03

    Nomeação de Mr Andrew Mark Glennon como diretor em 28/01/2020

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2017

    14 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/12/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    6 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 11/06/2016

    6 páginasAA

    Quem são os diretores de DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Secretário
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960890001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Diretor
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Diretor
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Secretário
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    PARAMORE, Neil
    Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Secretário
    Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209557760001
    SHEERIN, Clare
    8 College Place
    SO15 2FF Southampton
    Hampshire
    Secretário
    8 College Place
    SO15 2FF Southampton
    Hampshire
    British116312770001
    WILLSON, Michael Eric Anthony
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    Secretário
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    British7439200002
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965170002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretário
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secretário
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    GUYER, John Hugh
    Thatched Cottage
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    Diretor
    Thatched Cottage
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    British35529950003
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Diretor
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Diretor
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Diretor
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001
    WILLSON, Michael Eric Anthony
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish7439200002

    Quem são as pessoas com controle significativo de DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06/04/2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05382157
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating security document
    Criado em 04/04/2007
    Entregue em 17/04/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 17/04/2007Registro de uma garantia (395)
    • 13/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Criado em 08/02/2007
    Entregue em 14/02/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/02/2007Registro de uma garantia (395)
    • 13/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 13/10/2006
    Entregue em 19/10/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/10/2006Registro de uma garantia (395)
    • 23/05/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 18/02/2000
    Entregue em 23/02/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    2 bellvue road southampton. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/02/2000Registro de uma garantia (395)
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 30/04/1999
    Entregue em 13/05/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Freehold property k/a 1 the broadway portswood southampton hampshire t/ HP281708. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 13/05/1999Registro de uma garantia (395)
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 15/01/1997
    Entregue em 23/01/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H 61 commercial road totton southampton hampshire t/no hp 407319 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/01/1997Registro de uma garantia (395)
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 23/08/1993
    Entregue em 26/08/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £86,450 and all other moneys due from the company to the chargee
    Breve descrição
    1 the broadway portswood southampton hampshire.
    Pessoas com direito
    • Lordsvale Finance PLC
    Transações
    • 26/08/1993Registro de uma garantia (395)
    • 09/09/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 03/06/1992
    Entregue em 08/06/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    30 and 32 high road,swaythling,southampton,hampshire.t/nos. Hp 178279 and hp 129297 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/06/1992Registro de uma garantia (395)
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 10/12/1987
    Entregue em 17/12/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h and l/h property k/a 208 burgess road, southampton and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 17/12/1987Registro de uma garantia
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 06/10/1983
    Entregue em 17/10/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    32/34 beech road millbrook southampton t/n:- HP147635 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 17/10/1983Registro de uma garantia
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/10/1983
    Entregue em 17/10/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    110A bevois valley road, southampton t/n:- HP171846. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 17/10/1983Registro de uma garantia
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 06/10/1983
    Entregue em 10/10/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H eatamasan cafe and adjaning premises at 1A & 1B weston lane woolston, southampton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 10/10/1983Registro de uma garantia
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 22/08/1980
    Entregue em 10/09/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 27,000
    Breve descrição
    32/34 beech road, millbrook southampton, hampshire 110A bevois valley road southampton, hampshire.
    Transações
    • 10/09/1980Registro de uma garantia
    • 13/10/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Collateral legal charge
    Criado em 03/03/1980
    Entregue em 10/03/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 7,000.00
    Breve descrição
    110A bevois valley rd southampton, hampshire.
    Pessoas com direito
    • Brettan Mortgage Investments (Hampshire) LTD
    Transações
    • 10/03/1980Registro de uma garantia
    Collateral legal charge
    Criado em 03/03/1980
    Entregue em 10/03/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Sterling pounds 7,000.00
    Breve descrição
    23/34 beech rd, millbrook southampton, hampshire T. no. HP147635.
    Pessoas com direito
    • Brettan Mortgage Investments (Hampshire) LTD
    Transações
    • 10/03/1980Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0