FURNIVAL ESTATES LIMITED

FURNIVAL ESTATES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaFURNIVAL ESTATES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00758082
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
    • Compra e venda de imóveis próprios (68100) / Atividades imobiliárias
    • Arrendamento e exploração de imóveis de sociedades de habitação (68201) / Atividades imobiliárias

    Onde fica FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2012

    Qual é o status da última declaração anual para FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    2 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 24/08/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/09/2013

    Estado do capital em 02/09/2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2012

    13 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/08/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2011

    16 páginasAA

    O processo de dissolução compulsória foi descontinuado

    1 páginasDISS40

    Declaração anual preparada até 24/08/2011

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2010

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/08/2010

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2009

    14 páginasAA

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Detalhes do diretor alterados para Christopher George White em 01/05/2010

    3 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Maurice Moses Benady em 01/05/2010

    3 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2008

    15 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Quem são os diretores de FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretário
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Diretor
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Diretor
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Diretor
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretário
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretário
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secretário
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secretário
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Diretor
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Diretor
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Diretor
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Diretor
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Diretor
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    FURNIVAL ESTATES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 19/09/2007
    Entregue em 26/09/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transações
    • 26/09/2007Registro de uma garantia (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Criado em 28/01/2002
    Entregue em 06/02/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The leasehold land known as land ajoining eyre street, furnival street, matilda way and matilda street, sheffield. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transações
    • 06/02/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Criado em 03/08/1999
    Entregue em 16/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 23/12/1992
    Entregue em 06/01/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £87,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed
    Breve descrição
    Together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon (for full details of charge see form 395 and contd sheet).
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transações
    • 06/01/1993Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Second supplemental charge deed
    Criado em 04/12/1992
    Entregue em 08/12/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    Redvers house union street sheffield south yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transações
    • 08/12/1992Registro de uma garantia (395)
    • 22/10/1996Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 27/07/1999Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 17/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 21/11/1990
    Entregue em 29/11/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Redvers marse furnival street sheffield t/n: ywe 60547 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/11/1990Registro de uma garantia
    • 15/01/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Further charge
    Criado em 19/09/1978
    Entregue em 20/09/1978
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,240,000 and all other monies due or to become due from evans of leeds limited to the chargee under the terms of a deed dated 17-6-61.
    Breve descrição
    Land and buildings situate in sheffield being furnival house, furnival gate, as comprised in a lease dated 15-11-65.
    Pessoas com direito
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transações
    • 20/09/1978Registro de uma garantia
    • 27/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 30/06/1975
    Entregue em 02/07/1975
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Redvers slouse, furnival street, sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Coventry Bank LTD
    Transações
    • 02/07/1975Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Dep of title deed w/i
    Criado em 23/12/1971
    Entregue em 28/12/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £650,000
    Breve descrição
    Property at junction of union st and furnival gate, sheffield, known as redvers house.
    Pessoas com direito
    • The Bank of Nova Scotia
    Transações
    • 28/12/1971Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A registered charge
    Criado em 17/06/1971
    Entregue em 28/06/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,335,000 & all other monies due or to become due from evans of leeds LTD to the chargee any account whatsoever.
    Breve descrição
    Furnival house, furnival gate, sheffield comprised in a lease dated 15/11/65.
    Pessoas com direito
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transações
    • 28/06/1971Registro de uma garantia
    • 27/07/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 04/12/1970
    Entregue em 08/12/1970
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £800,000 due from lonsdale properties LTD to the chargers and for further securing £700,000 outstanding under 2 charges dated respectively 24/06/68 and 30/12/68 and due from the company millshaw property co. LTD and mulgate investments LTD to the chargee.
    Breve descrição
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way and matilda st, sheffield known as furnival house.
    Pessoas com direito
    • Old Broad Street Securiting LTD
    Transações
    • 08/12/1970Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/12/1968
    Entregue em 09/01/1969
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £427,000 & further securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68, all due from the company and the three other companies referred to therein
    Breve descrição
    Land containing 891 square yards at the junction of furnival st & union lane in the city of sheffield.
    Pessoas com direito
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transações
    • 09/01/1969Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 30/12/1968
    Entregue em 09/01/1969
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    For securing £427,000 & furthe securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68. all due from the company and three other companies referred to therein.
    Breve descrição
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way, & matilda st, sheffield. 4833 square yards approx.
    Pessoas com direito
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transações
    • 09/01/1969Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 24/06/1968
    Entregue em 28/06/1968
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Securing £345,000 and all other monies due or to become due from the co, to the chargee on any{ account whatsoever
    Breve descrição
    Land adjoining eyre street,furnival street matilda way and matilda street sheffield together with the buildings erected thereon. (See doc 20).
    Pessoas com direito
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transações
    • 28/06/1968Registro de uma garantia
    • 08/05/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0