GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00761460 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Roger Mclaughlan como diretor em 01/02/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Mary Elizabeth Bourlet como secretário em 01/02/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Laura Harradine-Greene como secretário em 01/02/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 25/12/2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mary Elizabeth Murray em 12/05/2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 03/04/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Justin Matthew King como diretor em 31/10/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mary Elizabeth Murray como secret ário em 25/08/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/12/2015 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Segunda apresentação para a cessação de funções de Nils Olin Steinmeyer como administrador | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Segunda apresentação para a cessação de funções de Kevin Michael Bradshaw como administrador | 4 páginas | RP04TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Justin Matthew King como diretor em 18/08/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Stephen Thomas Murphy como diretor em 18/08/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 22/07/2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 28/04/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Stephen Thomas Murphy como diretor em 06/04/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Roger Mclaughlan como diretor em 10/03/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Nils Olin Steinmeyer como diretor em 06/04/2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRADINE-GREENE, Laura | Secretário | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 242724460001 | |||||||
| JONES, Anthony Gerald | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 212265950002 | |||||
| ALLAN, John Michael | Secretário | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Secretário | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 217311710002 | |||||||
| COX, Peter John | Secretário | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| JONES, Anthony David | Secretário | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | 73622510001 | ||||||
| MURFIN, Stephen | Secretário | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Secretário | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | 76162020001 | ||||||
| SOUTHWELL, Alan David | Secretário | 41 Rectory Lane Byfleet KT14 7LR West Byfleet Surrey | British | 17536350001 | ||||||
| ALLAN, John Michael | Diretor | 37 Cavendish Drive Claygate KT10 0QE Esher Surrey | British | 17536370001 | ||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 124019940001 | |||||
| BRIGDEN, Peter | Diretor | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 195802400001 | |||||
| CHARLTON, John Fraser | Diretor | 4 Selwood Place SW7 3QQ London | British | 17536360001 | ||||||
| COX, Peter John | Diretor | 57 Gleneldon Road Streatham SW16 2BH London | British | 58964650001 | ||||||
| FAVELL, Gary Alan | Diretor | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | 107699240001 | |||||
| FISHER, Guy Norman | Diretor | 1 Beverley Road SW13 0LX London | United Kingdom | British | 17536380002 | |||||
| HEWITT, Robert John | Diretor | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | 15486070002 | |||||
| HODKINSON, James Clifford | Diretor | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 606430001 | |||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Diretor | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| KING, Justin Matthew | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 213043730001 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Diretor | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LIVINGSTON, William Andrew | Diretor | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | 111439220001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Diretor | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCINTYRE, Duncan Keith | Diretor | 24 Rounton Road Church Crookham GU13 0HB Fleet Hampshire | British | 29885580001 | ||||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | 206428840001 | |||||
| MURFIN, Stephen | Diretor | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | 207509410001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Diretor | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| PRICE, Glyn John | Diretor | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | 73470720001 | |||||
| RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Diretor | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | 76162020001 | |||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Diretor | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| STEVENSON, Barry John | Diretor | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | 102595670001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyevale Garden Centre Holdings Limited | 06/04/2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Criado em 24/02/2009 Entregue em 04/03/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 23/02/1995 Entregue em 06/03/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 23/02/1995 Entregue em 06/03/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/Hold property known as land lying to the north east of rousebarn lane chandlers cross hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 183142. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 23/02/1995 Entregue em 06/03/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/Hold property known as marlow garden centre (formerly thames valley garden centre) little marlow buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal mortgage | Criado em 23/02/1995 Entregue em 06/03/1995 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/Hold property known as palmers nurseries fir tree hill chandlers cross sarratt hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 92718. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0