GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED

GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00761460
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Roger Mclaughlan como diretor em 01/02/2019

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Mary Elizabeth Bourlet como secretário em 01/02/2018

    1 páginasTM02

    Nomeação de Laura Harradine-Greene como secretário em 01/02/2018

    2 páginasAP03

    Contas de micro-entidade preparadas até 25/12/2016

    4 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Mary Elizabeth Murray em 12/05/2017

    1 páginasCH03

    Declaração de confirmação apresentada em 28/04/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 03/04/2017

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Justin Matthew King como diretor em 31/10/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mary Elizabeth Murray como secretário em 25/08/2016

    2 páginasAP03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/12/2015

    9 páginasAA

    Segunda apresentação para a cessação de funções de Nils Olin Steinmeyer como administrador

    4 páginasRP04TM01

    Segunda apresentação para a cessação de funções de Kevin Michael Bradshaw como administrador

    4 páginasRP04TM01

    Nomeação de Mr Justin Matthew King como diretor em 18/08/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen Thomas Murphy como diretor em 18/08/2016

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Anthony Gerald Jones em 22/07/2016

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 28/04/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital18/05/2016

    Estado do capital em 18/05/2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomeação de Mr Stephen Thomas Murphy como diretor em 06/04/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Roger Mclaughlan como diretor em 10/03/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nils Olin Steinmeyer como diretor em 06/04/2016

    2 páginasTM01
    Anotações
    DataAnotação
    22/09/2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Quem são os diretores de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Secretário
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    242724460001
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish212265950002
    ALLAN, John Michael
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    Secretário
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    British17536370001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Secretário
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    217311710002
    COX, Peter John
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    Secretário
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    British58964650001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Secretário
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    British73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Secretário
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    British8690590001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Secretário
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    British76162020001
    SOUTHWELL, Alan David
    41 Rectory Lane
    Byfleet
    KT14 7LR West Byfleet
    Surrey
    Secretário
    41 Rectory Lane
    Byfleet
    KT14 7LR West Byfleet
    Surrey
    British17536350001
    ALLAN, John Michael
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    Diretor
    37 Cavendish Drive
    Claygate
    KT10 0QE Esher
    Surrey
    British17536370001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Diretor
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish195802400001
    CHARLTON, John Fraser
    4 Selwood Place
    SW7 3QQ London
    Diretor
    4 Selwood Place
    SW7 3QQ London
    British17536360001
    COX, Peter John
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    Diretor
    57 Gleneldon Road
    Streatham
    SW16 2BH London
    British58964650001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Diretor
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritish107699240001
    FISHER, Guy Norman
    1 Beverley Road
    SW13 0LX London
    Diretor
    1 Beverley Road
    SW13 0LX London
    United KingdomBritish17536380002
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Diretor
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritish15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Diretor
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish213043730001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Diretor
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritish1470180001
    MCINTYRE, Duncan Keith
    24 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0HB Fleet
    Hampshire
    Diretor
    24 Rounton Road
    Church Crookham
    GU13 0HB Fleet
    Hampshire
    British29885580001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritish206428840001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Diretor
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    British8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish207509410001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Diretor
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritish138653690001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Diretor
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritish73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Diretor
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritish76162020001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Diretor
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGerman126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Diretor
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish102595670001

    Quem são as pessoas com controle significativo de GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Wyevale Garden Centre Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06/04/2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House England And Wales
    Número de registro01972554
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    GREAT GARDENS OF ENGLAND INVESTMENTS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Security agreement
    Criado em 24/02/2009
    Entregue em 04/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transações
    • 04/03/2009Registro de uma garantia (395)
    • 04/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/02/1995
    Entregue em 06/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 23/02/1995
    Entregue em 06/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold property known as land lying to the north east of rousebarn lane chandlers cross hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 183142. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 23/02/1995
    Entregue em 06/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold property known as marlow garden centre (formerly thames valley garden centre) little marlow buckinghamshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 23/02/1995
    Entregue em 06/03/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold property known as palmers nurseries fir tree hill chandlers cross sarratt hertfordshire and the proceeds of sale thereof; t/no.hd 92718. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/03/1995Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0