RGB COFFEE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRGB COFFEE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00809039
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RGB COFFEE LIMITED?

    • (5137) /

    Onde fica RGB COFFEE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RGB COFFEE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ROMBOUTS COFFEE(G.B.)LIMITED15/06/196415/06/1964

    Quais são as últimas contas de RGB COFFEE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para RGB COFFEE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Suzanne Elizabeth Wise como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor em 15/11/2011

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 03/11/2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade

    2 páginasCC02

    Resoluções

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/08/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Ms Suzanne Elizabeth Wise em 01/08/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Simon Nicholas Wilbraham em 01/08/2011

    1 páginasCH03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    7 páginasAA

    Nomeação de Mr Antony David Smith como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Peeler como diretor

    2 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 15/11/2010 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Nomeação de Mr Simon Nicholas Wilbraham como diretor

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/11/2009 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Quem são os diretores de RGB COFFEE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director147725160001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretário
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretário
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary120645920001
    THOMSON, Iain Gordon
    15 Longstock Close
    Chineham
    RG24 8WR Basingstoke
    Hampshire
    Secretário
    15 Longstock Close
    Chineham
    RG24 8WR Basingstoke
    Hampshire
    British20418560001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    BritishFinance Director Chartered Acc73003300001
    BAKER, Peter
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    Diretor
    12 Tallow Road
    TW8 8EU Brentford
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector112123100001
    CAMPBELL, Angus Marshall
    Teals Point 2 Teals Way
    Lower Heswall
    CH60 4RX Wirral
    Diretor
    Teals Point 2 Teals Way
    Lower Heswall
    CH60 4RX Wirral
    BritishManaging Director84086680001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Diretor
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritishCompany Director27300002
    GEORGAKIS, Phillip
    The Farmhouse 38 Totternhoe Road
    Eaton Bray
    LU6 2BD Dunstable
    Bedfordshire
    Diretor
    The Farmhouse 38 Totternhoe Road
    Eaton Bray
    LU6 2BD Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director20418570001
    GRANT, Brian John
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director64875090001
    JAMES, Martin David
    Bloomfield Hatch Farm House
    Bloomfield Hatch, Mortimer
    RG7 3AD Reading
    Berkshire
    Diretor
    Bloomfield Hatch Farm House
    Bloomfield Hatch, Mortimer
    RG7 3AD Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector19988520002
    JARVIS, Mandy
    33 Burlington Avenue
    Kew
    TW9 4DS Richmond
    Surrey
    Diretor
    33 Burlington Avenue
    Kew
    TW9 4DS Richmond
    Surrey
    BritishFinance Director41692490001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Diretor
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritishDirector92817300001
    KNOX, Virginia Caroline
    Rowbarns Grange North
    Green Dene, East Horsley
    KT24 5RQ Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    Rowbarns Grange North
    Green Dene, East Horsley
    KT24 5RQ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director45852840005
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Diretor
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritishDirector99991140001
    LEWIS, David
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector69920630001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary/Director26880001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Counsel76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PASCOE, Nasim
    Waterspin
    Riverside
    TW18 3NH Staines
    Middlesex
    Diretor
    Waterspin
    Riverside
    TW18 3NH Staines
    Middlesex
    BritishFinance Director63497930001
    PEELER, Andrew Michael
    108 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    108 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EW Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Diretor
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Diretor
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector42065200002
    THOMSON, Iain Gordon
    15 Longstock Close
    Chineham
    RG24 8WR Basingstoke
    Hampshire
    Diretor
    15 Longstock Close
    Chineham
    RG24 8WR Basingstoke
    Hampshire
    BritishCompany Director20418560001
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Council/Company Secretary136781050001

    RGB COFFEE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/2004
    Entregue em 06/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 06/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited the chargors and the chargees (all as defined)
    Criado em 11/09/2000
    Entregue em 23/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York(As "Security Agent")
    Transações
    • 23/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0