TURBOFLEX LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTURBOFLEX LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00839728
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TURBOFLEX LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TURBOFLEX LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o BIBBY TRANSMISSIONS
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de TURBOFLEX LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para TURBOFLEX LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 29/12/2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Revoke auth cap restrictions 04/12/2017
    RES13

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 04/12/2017

    • Capital: GBP 1,717,000
    3 páginasSH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    6 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 14/12/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital14/12/2015

    Estado do capital em 14/12/2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 14/12/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/12/2014

    Estado do capital em 16/12/2014

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Carl Richard Christenson em 10/11/2013

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 14/12/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/12/2013

    Estado do capital em 19/12/2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Término da nomeação de Graham Varga como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Richard Ian Laws como secretário

    1 páginasAP03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 14/12/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Penelope Turvey como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Graham Varga como secretário

    2 páginasAP03

    Quem são os diretores de TURBOFLEX LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LAWS, Richard Ian
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Secretário
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    182626840001
    CHRISTENSON, Carl Richard
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Diretor
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    United StatesAmerican110880800002
    STORCH, Christian
    12 Preston Square
    Quincy
    Massachusetts Ma 02171
    United States
    Diretor
    12 Preston Square
    Quincy
    Massachusetts Ma 02171
    United States
    United StatesGerman126884910001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Secretário
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Secretário
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    British44039650003
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Secretário
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Usa33616600001
    BUCKLEY, Deryck Stephen
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    Secretário
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    British47883800001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Secretário
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    FITZPATRICK, Stephen Joseph
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    Secretário
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    British204911280005
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretário
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    British56115110001
    HALLAM, Peter Leslie
    25 Cambridge Road
    PE9 1BN Stamford
    Lincolnshire
    Secretário
    25 Cambridge Road
    PE9 1BN Stamford
    Lincolnshire
    British2258630001
    HARRISON, Brian
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    Secretário
    16 Briarwood Road
    GU21 1XD Woking
    Surrey
    British13648350001
    TURVEY, Penelope Ann
    182 High Street
    PE19 6SD Yelling
    Cambs
    Secretário
    182 High Street
    PE19 6SD Yelling
    Cambs
    British103094630002
    VARGA, Graham
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    Secretário
    c/o Bibby Transmissions
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    West Yorks
    British168160770001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretário
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    ABLITT, Ivor Geoffrey
    15 Tattershall Drive
    Market Deeping
    PE6 8BS Peterborough
    Cambridgeshire
    Diretor
    15 Tattershall Drive
    Market Deeping
    PE6 8BS Peterborough
    Cambridgeshire
    British3848360001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Diretor
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    American34721300001
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Diretor
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish44039650003
    BUCKLEY, Deryck Stephen
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    Diretor
    9 Halifax Road
    Staincliffe
    WF13 4AA Dewsbury
    West Yorkshire
    British47883800001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Diretor
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    BURDETT, Roger
    Yew Tree Cottage Mill Lane
    Lapworth
    B94 6HT Solihull
    West Midlands
    Diretor
    Yew Tree Cottage Mill Lane
    Lapworth
    B94 6HT Solihull
    West Midlands
    British53792200004
    BURNS, Christopher Peter
    Peters Farm
    Sulgrave Road Helmdon
    NN13 5QH Brackley
    Northamptonshire
    Diretor
    Peters Farm
    Sulgrave Road Helmdon
    NN13 5QH Brackley
    Northamptonshire
    British29017860001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Diretor
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    British33253280001
    FITZPATRICK, Stephen Joseph
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Maltings
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NS Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish204911280005
    FOX, David John
    58 North End Road
    Quainton
    HP22 4BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    58 North End Road
    Quainton
    HP22 4BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British4519410001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56115110001
    HERBAGE, Bernard Stanley
    Tanglewood Lodge
    Sycamore Road
    HP6 6BB Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Tanglewood Lodge
    Sycamore Road
    HP6 6BB Amersham
    Buckinghamshire
    British36629450001
    HOCKLEY, Donald Keith
    6 East Ridge
    SL8 5BX Bourne End
    Buckinghamshire
    Diretor
    6 East Ridge
    SL8 5BX Bourne End
    Buckinghamshire
    British13685820001
    KEITH, Percival Cleveland
    1 Turvey Close
    Aston Clinton
    HP22 5JG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    1 Turvey Close
    Aston Clinton
    HP22 5JG Aylesbury
    Buckinghamshire
    American13648320001
    LEWIS, Brian
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    Diretor
    The Hyde Mountnessing Road
    Blackmore
    CM4 0NX Ingatestone
    Essex
    British18905160001
    LOVE, Colin Wilson
    3 Andrews Way
    Raunds
    NN9 6RD Wellingborough
    Northamptonshire
    Diretor
    3 Andrews Way
    Raunds
    NN9 6RD Wellingborough
    Northamptonshire
    British65767530002
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    Diretor
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglish13447260001
    MCKELLER, Lawson
    122 Sheerstock
    HP17 8EX Haddenham
    Buckinghamshire
    Diretor
    122 Sheerstock
    HP17 8EX Haddenham
    Buckinghamshire
    British40188720001
    MIDSON, Anthony John
    27 Wymering Road
    HP21 9BP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    27 Wymering Road
    HP21 9BP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British13685830001
    RODGER, David Anthony Hugh
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    Diretor
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    British89739630001

    Quem são as pessoas com controle significativo de TURBOFLEX LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    Bibby Transmissions Ltd
    West Yorkshire
    England
    14/12/2016
    Cannon Way
    WF13 1EH Dewsbury
    Bibby Transmissions Ltd
    West Yorkshire
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalUk Companies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro158829
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    TURBOFLEX LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 08/03/2007
    Entregue em 10/03/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/03/2007Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 07/07/2000
    Entregue em 25/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 25/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 07/07/2000
    Entregue em 25/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the mezzanine documents (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Mithras Investment Trust,as Facility Agent for Itself and the Other Secured Parties,as Defined
    Transações
    • 25/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession and supplemental charge
    Criado em 27/03/1997
    Entregue em 08/04/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future sums, liabilities or obligations from time to time due, owing or incurred (actually or contingently) by chargeready limited (the principal borrower) or any other group company to the chargee as agent and security trustee for the beneficiaries (as defined) under or in connection with the facilities agreement (as defined) and/or any other senior finance document (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts patents buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 08/04/1997Registro de uma garantia (395)
    • 27/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over stocks shares or other securities
    Criado em 11/02/1994
    Entregue em 28/02/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a mortgage debenture dated 28 may 1993
    Breve descrição
    A specific charge over all stocks shares or other securities in any subsidiary companies or any other company for the time being.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 28/02/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balances
    Criado em 01/10/1993
    Entregue em 21/10/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The sum of £32,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 83557997 and earmarked or designated by reference to the company.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 21/10/1993Registro de uma garantia (395)
    • 20/11/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 28/05/1993
    Entregue em 08/06/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/06/1993Registro de uma garantia (395)
    • 06/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0