MISYS B & S DIVISION LIMITED

MISYS B & S DIVISION LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMISYS B & S DIVISION LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00844354
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    APRICOT COMPUTERS P.L.C.13/08/198513/08/1985

    Quais são as últimas contas de MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/05/2013

    Qual é o status da última declaração anual para MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    13 páginas4.71

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Contas anuais preparadas até 31/05/2013

    11 páginasAA

    Nomeação de Mrs Elizabeth Mary Collins como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Misys Corporate Director Limited como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Joanna Hawkes como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Misys Corporate Secretary Limited como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Sanjay Patel como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 16/08/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/09/2013

    Estado do capital em 02/09/2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Segunda apresentação de AR01 previamente entregue à Companies House elaborado em 16/08/2012

    16 páginasRP04

    Nomeação de Thomas Edward Timothy Homer como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Joanna Marageret Hawkes como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Bijal Patel como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/05/2012

    13 páginasAA

    Nomeação de Mr Bijal Mahendra Patel como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas Farrimond como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 16/08/2012 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Anotações
    DataAnotação
    27/08/2013A second filed AR01 was registered on 27/08/2013

    Nomeação de Misys Corporate Secretary Limited como secretário

    2 páginasAP04

    Término da nomeação de Sarah Brain como secretário

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Quem são os diretores de MISYS B & S DIVISION LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    Secretário
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid
    RH17 5SZ Haywards Heath
    No 1
    West Sussex
    England
    146626180001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretário
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretário
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretário
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretário
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Secretário
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretário
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secretário
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Secretário
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro07036299
    170448780001
    BURY, Lindsay Claude Neils
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    Diretor
    Millichope Park
    Munslow
    SY7 9HA Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish67103750001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FOSTER, Roger Keith
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    Diretor
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    EnglandBritish2551760001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Diretor
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Diretor
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HARFORD, John Timothy, Sir
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    Diretor
    South House
    South Littleton
    WR11 5TJ Evesham
    Worcestershire
    British15932250001
    HART, Michael John
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    Diretor
    The White House
    Lower Illey
    B62 0HJ West Midlands
    British118672700001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JONES, Miah Gwynfor
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    Diretor
    Box Farm Reynoldston
    SA3 1AA Swansea
    British66161140001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MACPHERSON, Philip Strone Stewart
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    Diretor
    Armsworth Park House
    Armsworth Park
    SO24 9RH Old Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish42864500001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Diretor
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Diretor
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NEWTON, Richard Paul
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    21 Priory Road
    Edgbaston
    B5 7UG Birmingham
    West Midlands
    British2551790001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PEDDER, Clive Thomas
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    Diretor
    Chuck Hatch House
    Chuck Hatch
    TN7 4EX Hartfield
    East Sussex
    United KingdomBritish71955460001
    SOLOMONS, Anthony Nathan
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    Diretor
    10 Constable Close
    NW11 6TY London
    United KingdomBritish8116770001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Diretor
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Diretor
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    Diretor
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001

    MISYS B & S DIVISION LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Criado em 17/09/2003
    Entregue em 01/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Criado em 11/09/2003
    Entregue em 24/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Criado em 29/07/2003
    Entregue em 12/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 12/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Criado em 23/10/2002
    Entregue em 13/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Criado em 09/05/2002
    Entregue em 25/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 25/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Charge
    Criado em 22/06/1993
    Entregue em 01/07/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility letter, the guarantee and/or the counter indemnity
    Breve descrição
    All the company's rights to receive payment for or in respect of the new ordinary shares as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 01/07/1993Registro de uma garantia (395)
    • 06/12/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Trade marks mortgage
    Criado em 05/03/1990
    Entregue em 20/03/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All trade marks of the company. (See form M525C for full details).
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/03/1990Registro de uma garantia
    Guarantee & debenture
    Criado em 05/03/1990
    Entregue em 20/03/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/03/1990Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 14/08/1986
    Entregue em 16/08/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 11 february 1986.
    Breve descrição
    Leasehold property known as and being ground & upper basement floors 18/19 pall mall london SW1.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 16/08/1986Registro de uma garantia
    Standard security
    Criado em 17/02/1986
    Entregue em 20/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    1.513 hectares at rutherford rd, southfield industrial estate, glenrothes, fife with factory buildings thereon k/a 29 rutherford road, glenrothes. 0.340 hectare comprising car park at rutherford road, southfield industrial estate.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 20/02/1986Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 21/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The research and development centre at vincent drive, edgbaston, b'ham. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 21/02/1986Registro de uma garantia
    • 05/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment and of present and future copyright by way of security charge
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 14/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Breve descrição
    The charged rights is defined to mean all the copyrights, rights in the nature of copyright and other rights, causes of action and interests assured assigned or charged. For fuller details see doc M78.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 14/02/1986Registro de uma garantia
    Charge over goodwill trademarks & tradenames.
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 14/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any accounts whatsoever.
    Breve descrição
    "The charged rights is defined to mean all trademarks, applications for trademarks, tradenames and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. For fuller details see DOCM77.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 14/02/1986Registro de uma garantia
    Assignment and of patents by way of security charge
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 14/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Breve descrição
    The charged rights is defined to mean all patents patent applications and other rights, causes of action and interests assured, assigned or charged. See doc M76 for fuller details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks.
    Transações
    • 14/02/1986Registro de uma garantia
    Assignment and of registered designs by way of security charge
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 14/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever.
    Breve descrição
    The charged rights is defined to mean all registered designs applications for registered designs and other rights causes of action and interests assured assigned or charged. For further details see doc M75.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 14/02/1986Registro de uma garantia
    • 05/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 11/02/1986
    Entregue em 12/02/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever
    Breve descrição
    Including trade fixtures see doc M74 for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Banks
    Transações
    • 12/02/1986Registro de uma garantia
    Legal mortgage
    Criado em 22/07/1985
    Entregue em 23/07/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Act house, 111 hagley road, edgbaston, birmingham, w mids t/n wk 50832.
    Pessoas com direito
    • The British Linen Bank Limited
    Transações
    • 23/07/1985Registro de uma garantia
    Letter of charge
    Criado em 10/06/1985
    Entregue em 26/07/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account whether already opened or to be opened hereafter and in whatever currency such account may be denominated and whether with the bank or opened by the bank (whether in the name of the company or not) on the company's behalf with some 3RD party for the deposit of moneys of the company.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/07/1985Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 08/02/1985
    Entregue em 18/02/1985
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Elizabeth house 17 westbourne road, and the lodge 17A, westbourne road, edgbaston, w midlands. T/n WM28511 wm 312841.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 18/02/1985Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 29/09/1983
    Entregue em 05/10/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    L/H 111 hagley road edgbaston birmingham title no wk 50832.
    Pessoas com direito
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transações
    • 05/10/1980Registro de uma garantia
    Legal charge
    Criado em 13/07/1983
    Entregue em 19/07/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    F/H property situate at & known as shenstone house, halesowen west midlands.
    Pessoas com direito
    • The British Linen Bank Limited
    Transações
    • 19/07/1983Registro de uma garantia
    Further guarantee & debenture
    Criado em 24/09/1980
    Entregue em 06/10/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/10/1980Registro de uma garantia

    MISYS B & S DIVISION LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    01/07/2014Data de dissolução
    19/12/2013Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profissional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0