STRONGDRAW LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | STRONGDRAW LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 00853356 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de STRONGDRAW LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica STRONGDRAW LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Avis Budget House Park Road RG12 2EW Bracknell, Berkshire England England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de STRONGDRAW LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
BARCELSURE LIMITED | 02/07/1965 | 02/07/1965 |
Quais são as últimas contas de STRONGDRAW LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para STRONGDRAW LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 13/09/2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 05/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Paul Edward Rollason em 26/03/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Inderpal Lall como secretário em 20/07/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Gail Marion Jones como secretário em 20/07/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 05/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 17 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 05/04/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 7 Welbeck Street London W1G 9YE para Avis Budget House Park Road Bracknell, Berkshire England RG12 2EW em 10/11/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Broughton Secretaries Limited como secretário em 07/11/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Paul Edward Rollason como diretor em 30/06/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Joanna Elizabeth Spiers como diretor em 30/06/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 05/04/2016 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||||||
Nomeação de Paul Leslie Ford como diretor em 30/04/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Jason Christopher Godsell Turner como diretor em 30/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 05/04/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Quem são os diretores de STRONGDRAW LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALL, Inderpal | Secretário | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 248830160001 | |||||||||||
FORD, Paul Leslie | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 197045450001 | ||||||||
ROLLASON, Paul Edward | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 168157490002 | ||||||||
JONES, Gail Marion | Secretário | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | 177025200001 | |||||||||||
NICHOLSON, Judith Ann | Secretário | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks England | British | 27201530002 | ||||||||||
BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Secretário | Welbeck Street W1G 9YE London 7 England |
| 86181860001 | ||||||||||
BELL, Nina Anne | Diretor | 11 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | England | British | Accountant | 99807710003 | ||||||||
CATHCART, William Alun | Diretor | Robin Rag The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | British | Company Director | 9490580007 | |||||||||
COATES, Richard John | Diretor | 7 Spinfield Lane West SL7 2DB Marlow Bucks | British | Vice President | 81363010001 | |||||||||
COWAN, Christopher Ian | Diretor | Ballards Ballards Lane RH8 0SN Limpsfield Surrey | British | Group Finance Director | 54679190001 | |||||||||
DO CARMO, Joao Humberto Deus | Diretor | Avenue Do Colegio Militar No 7-1 Esq 1500-179 Lisboa Portugal | Portugese | Business Executive | 43794860002 | |||||||||
FILLINGHAM, Stuart Barry David | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | England | British | Accountant | 99807720001 | ||||||||
FORD, Paul Leslie | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berkshire England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 45288050004 | ||||||||
GATES, Edwin Peter | Diretor | Westcott 5 Millhedge Close KT11 3BE Cobham Surrey | United Kingdom | British | Vice President Treasury | 38944950001 | ||||||||
HANNA, Kenneth George | Diretor | 5 Onslow Drive Ascot Mansions SL5 7UL North Ascot Berkshire | British | Company Director | 78515410001 | |||||||||
MALONEY, David Ossian | Diretor | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 69071800002 | ||||||||
MCCAFFERTY, Mark | Diretor | 39 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | United Kingdom | British | Chief Executive | 61788610002 | ||||||||
RONCADIN, Gianfranco | Diretor | Via Camillo Mariani N 2/E FOREIGN Rome 00135 Italy | Italian | General Manager | 66344920001 | |||||||||
SACHDEVA, Rajiv | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis House Berks United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 169861260001 | ||||||||
SMITH, Martyn Robert | Diretor | 61 Esmond Road W4 1JE London | England | British | Accountant | 100650660001 | ||||||||
SPIERS, Joanna Elizabeth | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 178651670001 | ||||||||
TURNER, Jason Christopher Godsell | Diretor | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 135757770001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de STRONGDRAW LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avis Europe Holdings Ltd | 30/06/2016 | Park Road RG12 2EW Bracknell Avis Budget House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
STRONGDRAW LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Criado em 11/08/1992 Entregue em 18/08/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to any of the facility documents or any of the consortium documents on any account whatsoever | |
Breve descrição All estates rights and interest in f/h and l/h property for full details see form 395. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Guarantee and debenture | Criado em 07/08/1992 Entregue em 21/08/1992 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição See form 395 ref M104. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A deed of debenture | Criado em 26/10/1990 Entregue em 01/11/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All moneys due or to become due from the company to citibank N.A. (as security trustee for the beneficiaries) under the terms of the facility documents or any of the consortium documents and this charge (together the secured obligations) | |
Breve descrição (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 03/08/1990 Entregue em 18/08/1990 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement and this deed as defined therein. | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0