UWTS REALISATIONS LIMITED

UWTS REALISATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaUWTS REALISATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00858432
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de UWTS REALISATIONS LIMITED?

    • atividades de remediação e outros serviços de gestão de resíduos (39000) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação

    Onde fica UWTS REALISATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de UWTS REALISATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    UKDN WATERFLOW TECHNICAL SERVICES LIMITED04/05/201204/05/2012
    THE WATERFLOW GROUP LIMITED14/10/201114/10/2011
    THE WATERFLOW GROUP PLC26/08/200426/08/2004
    WATERFLOW SERVICES LIMITED25/08/200425/08/2004
    ONSITE SOUTH LIMITED15/10/200115/10/2001
    WATER FLOW SERVICES LIMITED07/09/196507/09/1965

    Quais são as últimas contas de UWTS REALISATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para UWTS REALISATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Relatório de progresso do administrador

    19 páginasAM10

    Aviso de mudança da administração para dissolução

    21 páginasAM23

    Aviso de ordem de remoção do administrador do cargo

    7 páginasAM16

    Relatório de progresso do administrador

    18 páginasAM10

    Relatório de progresso do administrador até 14/10/2016

    14 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 04/05/2016

    15 páginas2.24B

    Declaração de proposta do administrador

    45 páginas2.17B

    Declaração de negócios com formulário 2.14B

    8 páginas2.16B

    Endereço do domicílio registado alterado de Block a, the Courtyard, Langley Business Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6EZ para Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ em 13/11/2015

    2 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    1 páginas2.12B

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed ukdn waterflow technical services LIMITED\certificate issued on 11/11/15
    2 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name11/11/2015

    Aviso de alteração do nome"

    CONNOT

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Término da nomeação de John Henry Roger Foldes como diretor em 30/04/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de George Shannon como diretor em 30/04/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 24/01/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/03/2015

    Estado do capital em 02/03/2015

    • Capital: GBP 991,000
    SH01

    Nomeação de Mr John Henry Roger Foldes como diretor em 25/02/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen Frank Shine como diretor em 13/02/2015

    1 páginasTM01

    Registo da garantia 008584320016, criada em 05/02/2015

    36 páginasMR01

    Término da nomeação de Frederick George Danneau como secretário em 18/12/2014

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Sean Patrick Masterson como diretor em 26/11/2014

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de The Chapel Pinewood Court Coleshill Road Marston Green Birmingham B37 7HG para Block a, the Courtyard, Langley Business Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6EZ em 28/10/2014

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    23 páginasAA

    Registo da garantia 008584320015, criada em 08/08/2014

    8 páginasMR01

    Quem são os diretores de UWTS REALISATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARRIS, Nicholas James
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Diretor
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    EnglandBritishC.E.O.180674690001
    MOUATT, Kevin Clifford
    Beech Road
    Merstham
    RH1 3AE Redhill
    Beech Hanger
    England
    Diretor
    Beech Road
    Merstham
    RH1 3AE Redhill
    Beech Hanger
    England
    United KingdomBritishCoo69437270002
    BRITTON, Christopher Robert
    30 Basford Way
    SL4 4NF Windsor
    Berkshire
    Secretário
    30 Basford Way
    SL4 4NF Windsor
    Berkshire
    British77300200002
    COOK, Paul
    26 Palmers Close
    Cox Green
    SL6 3XF Maidenhead
    Berkshire
    Secretário
    26 Palmers Close
    Cox Green
    SL6 3XF Maidenhead
    Berkshire
    BritishAccountant48360320001
    DANNEAU, Frederick George
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12-16
    England
    Secretário
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12-16
    England
    186086130001
    HICKEY, Eric Patrick
    4 The Covert
    HA6 2UD Northwood
    Middlesex
    Secretário
    4 The Covert
    HA6 2UD Northwood
    Middlesex
    British23992860001
    LEVY, Charles Michael
    10 Langland Court
    HA6 2NH Northwood
    Middlesex
    Secretário
    10 Langland Court
    HA6 2NH Northwood
    Middlesex
    British4118780001
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Secretário
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    POWELL, Christopher Gary
    11 Lords Drive
    St George
    TF2 9UE Telford
    Salop
    Secretário
    11 Lords Drive
    St George
    TF2 9UE Telford
    Salop
    British125639870001
    BAYLIS, Simon Andrew
    12 The Paddock
    OX11 0QU Chilton
    Oxfordshire
    Diretor
    12 The Paddock
    OX11 0QU Chilton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishEngineer76257390001
    BEECH, Gregory Paul
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    Diretor
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    United KingdomBritishDirector92006500003
    DOWNES, Vernon
    Rose Cottage
    87 Cheapside Road
    SL5 7QG Ascot
    Berkshire
    Diretor
    Rose Cottage
    87 Cheapside Road
    SL5 7QG Ascot
    Berkshire
    BritishDirector76753060002
    ECKERSLEY, Paul Francis
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    Diretor
    Annandale
    Watling Street
    ME2 3UQ Higham
    Kent
    BritishAccountant76257460001
    FOLDES, John Henry Roger
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6EZ Slough
    Block A, The Courtyard, Langley Business Park
    England
    Diretor
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6EZ Slough
    Block A, The Courtyard, Langley Business Park
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer147238180002
    HARLEY, Robert Ian
    Little Brook End Farm
    Holdings Lane Kempsey
    WR5 3LF Worcester
    Diretor
    Little Brook End Farm
    Holdings Lane Kempsey
    WR5 3LF Worcester
    BritishDirector42785040001
    HICKEY, Eric Patrick
    4 The Covert
    HA6 2UD Northwood
    Middlesex
    Diretor
    4 The Covert
    HA6 2UD Northwood
    Middlesex
    BritishElectrical Retailer23992860001
    KERN, Leonard Ernest
    Little House
    Drakes Drive
    Northwood
    Middlesex
    Diretor
    Little House
    Drakes Drive
    Northwood
    Middlesex
    BritishConsultant23992870001
    KERN, Roger John Graham
    25 Links Way
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Diretor
    25 Links Way
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector99126140001
    LUSHER, Mark David
    Foxbush
    Hildenborough
    TN11 9HT Tonbridge
    3
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    Foxbush
    Hildenborough
    TN11 9HT Tonbridge
    3
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector (Rail)131288270001
    MASTERSON, Sean Patrick
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12-16
    England
    Diretor
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12-16
    England
    United KingdomBritishManaging Director123333600003
    PACE, Stuart
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    England
    Diretor
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    England
    United KingdomBritishDirector97264740002
    PAGE, Adrian Peter
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    Diretor
    11 Shadows Lane
    Congerstone
    CV13 6NF Nuneaton
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant50576960001
    REILLY, Nicholas
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12
    England
    Diretor
    David Road
    Colnbrook
    SL3 0DG Slough
    12
    England
    EnglandBritishManaging Director134505900001
    RHODES, Jonathan Edward
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    England
    Diretor
    Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HG Birmingham
    The Chapel Pinewood Court
    England
    EnglandBritishFinance Director148428870001
    ROBERTSON, Philip John Anthony
    The Warren
    Potter Row
    HP16 9LT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Warren
    Potter Row
    HP16 9LT Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector20626440003
    SHANNON, George
    10b Bonfield Road
    Strathkinness
    KY16 9RP St. Andrews
    Glen Clova
    Fife
    Scotland
    Diretor
    10b Bonfield Road
    Strathkinness
    KY16 9RP St. Andrews
    Glen Clova
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishCfo91713170002
    SHINE, Stephen Frank
    Pinewood Court
    Coleshill Road Marston Green
    B37 7HG Solihull
    The Chapel
    Uk
    Diretor
    Pinewood Court
    Coleshill Road Marston Green
    B37 7HG Solihull
    The Chapel
    Uk
    EnglandBritishDirector122178710001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Diretor
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    BritishFinancial Accountant36622750002

    UWTS REALISATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 05/02/2015
    Entregue em 09/02/2015
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Lyceum Capital Industrial Partners Fund Ii
    • Lyceum Capital Fund Ii B
    • Lyceum Capital Fund Ii A
    Transações
    • 09/02/2015Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 08/08/2014
    Entregue em 08/08/2014
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Five Arrows Business Finance PLC
    Transações
    • 08/08/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 19/06/2014
    Entregue em 19/06/2014
    Pendente
    Breve descrição
    Assignment.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transações
    • 19/06/2014Registro de uma garantia (MR01)
    Deed of accession
    Criado em 14/10/2011
    Entregue em 21/10/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 21/10/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Legal assignment
    Criado em 31/08/2010
    Entregue em 02/09/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 02/09/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Criado em 25/08/2010
    Entregue em 27/08/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets plus see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transações
    • 27/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Debenture
    Criado em 25/06/2010
    Entregue em 29/06/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 29/06/2010Registro de uma garantia (MG01)
    All assets debenture
    Criado em 29/10/2009
    Entregue em 04/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 04/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 06/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Criado em 24/08/2004
    Entregue em 03/09/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as onsite south limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The chattels being mercedes vacuum tanker registration number P525DPF, combo jet vacuum unit registration number P819PHY, vaccum tanker registration number RA51UCU, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 03/09/2004Registro de uma garantia (395)
    • 26/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 24/08/2004
    Entregue em 28/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly k/a onsite south limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 28/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Criado em 05/08/2004
    Entregue em 12/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property set out in the schedule to the mortgage.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 12/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A credit agreement
    Criado em 18/03/1993
    Entregue em 25/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £38907.18 due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descrição
    All its right title and interst in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 25/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Credit agreement
    Criado em 02/04/1992
    Entregue em 23/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £38274.84 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    All its right, title and interest in andto all sums payable (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Close Brothers Limited
    Transações
    • 23/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 25/03/1992
    Entregue em 30/03/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 30/03/1992Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 27/07/1989
    Entregue em 03/08/1989
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    14 and 16 david road, colnbrook, spelthorne, surrey t/n sy 353492 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 03/08/1989Registro de uma garantia
    • 14/12/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage
    Criado em 09/07/1979
    Entregue em 18/07/1979
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land & premises situate and known as 1 and 2 farm cottages, goulds green, hillingdon title no mx 278556.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 18/07/1979Registro de uma garantia
    • 08/12/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    UWTS REALISATIONS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    05/11/2015Início da administração
    07/11/2017Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Paul James Meadows
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Profissional
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    William Kenneth Dawson
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Profissional
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Profissional
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0