COMPASS ESTATES LIMITED

COMPASS ESTATES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOMPASS ESTATES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00932583
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COMPASS ESTATES LIMITED?

    • (6523) /

    Onde fica COMPASS ESTATES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O TENEO RESTRUCTURING LIMITED
    156 Great Charles Street Quuensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de COMPASS ESTATES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2009

    Quais são as últimas submissões para COMPASS ESTATES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Endereço do domicílio registado alterado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN para 156 Great Charles Street Quuensway Birmingham West Midlands B3 3HN em 07/09/2021

    2 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR para 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN em 28/06/2021

    2 páginasAD01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2020

    7 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2019

    12 páginasLIQ03

    Término da nomeação de Barbara Anne Mcall como diretor em 03/09/2019

    1 páginasTM01

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2018

    12 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2017

    12 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    10 páginasLIQ10

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    5 páginasNDISC

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2016

    10 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2015

    12 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2014

    11 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 28/11/2013

    11 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/09/2012

    11 páginas4.68

    O endereço de inspeção do registo foi alterado

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de * 1 Aldermanbury Square London EC2V 7SB* em 10/10/2011

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Declaração de solvência

    4 páginas4.70

    Quem são os diretores de COMPASS ESTATES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SC (SECRETARIES) LIMITED
    1 Aldermanbury Square
    EC2V 7SB London
    Secretário
    1 Aldermanbury Square
    EC2V 7SB London
    126490730001
    SNOW, Averina Anita
    59 Spencer Road
    TW2 5TG Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    59 Spencer Road
    TW2 5TG Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish67192720001
    DAVIES, William Norman
    1 Maple Tree Close
    Radyr
    CF4 8RU Cardiff
    South Glamorgan
    Secretário
    1 Maple Tree Close
    Radyr
    CF4 8RU Cardiff
    South Glamorgan
    British146426880001
    HICKS, Colin Geoffrey
    9 Llandaff Close
    CF64 3JH Penarth
    South Glamorgan
    Secretário
    9 Llandaff Close
    CF64 3JH Penarth
    South Glamorgan
    British7627930001
    MOORE, Sarah Alison
    62 Ty Draw Road
    Penylan
    CF23 5HD Cardiff
    South Glamorgan
    Secretário
    62 Ty Draw Road
    Penylan
    CF23 5HD Cardiff
    South Glamorgan
    British118820740001
    SKIPPEN, Terry Charles
    61 Richmond Road
    Leytonstone
    E11 4BX London
    Secretário
    61 Richmond Road
    Leytonstone
    E11 4BX London
    British54597200001
    ANGEL, Robert Evan Stanley
    47 Evelyn Avenue
    HA4 8AR Ruislip
    Middlesex
    Diretor
    47 Evelyn Avenue
    HA4 8AR Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritish57313670001
    BAMFORD, Julie
    18 Abbey Road
    EX4 7BG Exeter
    Devon
    Diretor
    18 Abbey Road
    EX4 7BG Exeter
    Devon
    EnglandBritish53637130001
    BENTLEY, Gordon Andrew
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    7 Hollybush Lane
    AL5 4AL Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish43125610002
    BLAKE, Brendan Patrick Paul
    Woodlands House Devauden Road
    St Arvens
    NP6 6EZ Chepstow
    Gwent
    Diretor
    Woodlands House Devauden Road
    St Arvens
    NP6 6EZ Chepstow
    Gwent
    British8309510001
    BRIMACOMBE, David John
    Edlins
    Aston Upthorpe
    OX11 9EF Didcot
    Oxfordshire
    Diretor
    Edlins
    Aston Upthorpe
    OX11 9EF Didcot
    Oxfordshire
    British88602930001
    BROWN, Charles Bennett
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    Diretor
    The Old Library
    High Street
    BS40 5QA Wrington Bristol
    Avon
    British107840600001
    FRANCIS, Malcolm John
    Rundstedt
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Diretor
    Rundstedt
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    British61845570001
    HARVEY, Deborah
    Euronext Liffe Cannon Bridge House
    1 Cousin Lane
    EC4R 3XX London
    Diretor
    Euronext Liffe Cannon Bridge House
    1 Cousin Lane
    EC4R 3XX London
    British62614370002
    HAYMAN, Martin Heathcote
    12 Brookfield Park
    NW5 1ER London
    Diretor
    12 Brookfield Park
    NW5 1ER London
    EnglandBritish5900650001
    HODDELL, John
    71 St Michaels Road
    Llandaff
    CF5 2AN Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    71 St Michaels Road
    Llandaff
    CF5 2AN Cardiff
    South Glamorgan
    British641910001
    JAIN, Sandeep Kumar
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomIndian154448750001
    MCALL, Barbara Anne
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish147969860019
    REDDING, Donald Thomas
    4 Auckland Road
    NP9 3QW Newport
    Gwent
    Diretor
    4 Auckland Road
    NP9 3QW Newport
    Gwent
    British4775770001
    RICHMOND, Simon John
    Heritage House 20 Badgers Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6UE Chepstow
    Gwent
    Diretor
    Heritage House 20 Badgers Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6UE Chepstow
    Gwent
    British74691050001
    SKIPPEN, Terry Charles
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    Diretor
    Basinghall Avenue
    EC2V 5DD London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish54597200001
    WEBB, Anthony Clifford
    Swn Y Don East Cliff South Gate
    Gower
    SA3 2AS Swansea
    West Glamorgan
    Diretor
    Swn Y Don East Cliff South Gate
    Gower
    SA3 2AS Swansea
    West Glamorgan
    British59883600001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Diretor
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish45988970001

    COMPASS ESTATES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 22/07/1999
    Entregue em 06/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H wessex house east borough wimborne dorset-DT10261..together with all buildings and fixtures..fixed charge the goodwill of any business..floating charge all plant machinery equipment tools furniture etc and all its property assets & undertaking.
    Pessoas com direito
    • Chartered Trust PLC
    Transações
    • 06/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 24/11/1995
    Entregue em 06/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    66 bickenhall mansions and goodwill of any business. Floating charge over all plant machinery equipment tools furniture stock and all other goods and chattels. Floating charge over all property assets and undertaking present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Chartered Trust PLC
    Transações
    • 06/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 07/06/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 19/03/1992
    Entregue em 23/03/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Freehold land and buildings situate at and known as numbers 33, 35, 37, 39, 41 and 43 park road beckenham kent title no:- SGL517944 together with all fixtures now or at any time hereafter affixed thereto other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Pessoas com direito
    • Chartered Trust PLC
    Transações
    • 23/03/1992Registro de uma garantia (395)
    • 25/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/10/1991
    Entregue em 25/10/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land on the south side of sweets way barnet greater london title no. Mx 128132, the property formerly part of title no. Mx 128132 being that transferred by a transfer dated 12TH august 1991. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Pessoas com direito
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transações
    • 25/10/1991Registro de uma garantia
    • 25/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 18/10/1991
    Entregue em 25/10/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land at courtlands drive watford hertfordshire title no hd 273138. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Pessoas com direito
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transações
    • 25/10/1991Registro de uma garantia
    • 25/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/04/1970
    Entregue em 16/04/1970
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land adjoining dorothy street, st helens, lancs. Land west of sutton heath road,st helens lancs.
    Pessoas com direito
    • Julian S. & Hodge & Company Limited
    Transações
    • 16/04/1970Registro de uma garantia
    • 25/06/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    COMPASS ESTATES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/09/2011Início da liquidação
    05/01/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profissional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profissional
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0