00944891 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresa00944891 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00944891
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de 00944891 LIMITED?

    • (7499) /

    Onde fica 00944891 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o SAPA BUILDING SYSTEMS LIMITED
    5300 Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de 00944891 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SCANDINAVIAN ALUMINIUM PROFILES AB LIMITED24/12/196824/12/1968

    Quais são as últimas contas de 00944891 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2009

    Qual é o status da última declaração anual para 00944891 LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para 00944891 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Restauração por ordem judicial

    4 páginasAC92

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed sapa\certificate issued on 25/11/15
    páginasCERTNM

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Endereço do domicílio registado alterado de * Alexandra Way Ashchurch Tewkesbury Gloucestershire GL20 8NB* em 22/06/2011

    1 páginasAD01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 31/01/2011 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/02/2011

    Estado do capital em 01/02/2011

    • Capital: GBP 2,086,534
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 31/01/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Nigel Keith Sissons em 31/01/2010

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2007

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2006

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2005

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2004

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2003

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Quem são os diretores de 00944891 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretário
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant24297480001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant24297480001
    SISSONS, Nigel Keith
    c/o Sapa Building Systems Limited
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Sapa Building Systems Limited
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8TX Tewkesbury
    5300
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant80321870001
    MILTON, Raymond George
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Secretário
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British30257980002
    POWELL, Dominic Hugh
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Secretário
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    British24124960001
    BERGENHEM, Lars
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    Diretor
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    SwedishCompany Director78626550001
    ELLIOTT, Leslie Charles
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director3825910001
    GREENSLADE, Robin Alastair
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    Diretor
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishCompany Director4565340001
    HERRINGTON, Hugh Richard
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Diretor
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6360950001
    JOHANSSON, Mats Harald
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    4 Paddocks View
    Long Eaton
    NG10 3QF Nottingham
    Nottinghamshire
    SwedishManufacturing Director68575210001
    KEIJZER, Peter
    Volmachtenlaan 11 9331 Bk
    FOREIGN Norg
    Holland
    Diretor
    Volmachtenlaan 11 9331 Bk
    FOREIGN Norg
    Holland
    DutchCompany Director24124970001
    MILTON, Raymond George
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Diretor
    The Birches Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant30257980002
    MITCHELL, John
    23 Badgers Chase
    Tiln Lane
    DN22 6RX East Retford
    Nottinghamshire
    Diretor
    23 Badgers Chase
    Tiln Lane
    DN22 6RX East Retford
    Nottinghamshire
    BritishSales & Marketing Director60169480002
    POWELL, Dominic Hugh
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Cottage Wild Hill
    Teversal
    NG17 3JE Sutton In Ashfield
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director24124960001
    WHARMBY, Roger
    Twyn Trees 188 High Street
    Tibshelf
    DE55 5NE Alfreton
    Derbyshire
    Diretor
    Twyn Trees 188 High Street
    Tibshelf
    DE55 5NE Alfreton
    Derbyshire
    EnglandBritishLogistics Director52838660001

    00944891 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Letter of set-off
    Criado em 16/03/1984
    Entregue em 16/03/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 16/03/1984Registro de uma garantia
    Mortgage debenture
    Criado em 14/03/1983
    Adquirido em 30/06/1983
    Entregue em 18/07/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Nil at present
    Breve descrição
    The property as charged in the mortgage debenture dated 14TH march 1983 (please see doc M46).
    Pessoas com direito
    • London Interstate Bank Limited
    Transações
    • 18/07/1983Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 14/03/1983
    Entregue em 30/03/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Legal mortgage over land and bldgs lying to the south of manefield road, sawpit lane, tibshelf derbyshire title no dy 63242 and land at sawpit lane tibshelf derbyshire described in conveyance s dated 21.9.72 and 3.2.75 fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts uncalled capital. All stocks, shares and other interests, all patents, patent applications trade monies trade names etc. tog with all fixtures (inc-trade fixtures) fixed plant & machinery. (See doc-M41).
    Pessoas com direito
    • London Interstate Bank Limited
    Transações
    • 30/03/1983Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 22/10/1981
    Entregue em 23/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H & l/h properties present & future with fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery goodwill & uncalled capital present & future undertaking all other property & assets present & future inc heritable property & assets in scotland fixed & floating charge (see doc M40).
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 23/10/1981Registro de uma garantia
    Debenture
    Criado em 27/07/1981
    Entregue em 04/08/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed charge over f/h land at sawpit lane tibshelf, derbyshire title no dy 63242 tog with all other f/h & l/h property of the company present & future inc. All fixtures, fixed plant & machinery. All stocks, shares etc. uncalled capital goodwill patents trade marks etc. all book & other debts floating charge over the undertaking & all other property assets & rights.
    Pessoas com direito
    • Scandinavian Bank Limited
    Transações
    • 04/08/1981Registro de uma garantia
    Mortgage debenture as varied by a deed of variation dated 22ND october 1981
    Criado em 05/08/1980
    Adquirido em 30/06/1983
    Entregue em 20/07/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Nil at present
    Breve descrição
    The property as charged in the mortgage debenture dated 5TH august 1980 as varied by the dee dof variation dated 22ND october 1981 (please see doc M47).
    Pessoas com direito
    • Scandinavian Bank Limited
    Transações
    • 20/07/1983Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0