CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00981659
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RENTCO NATIONWIDE LIMITED09/06/197009/06/1970

    Quais são as últimas contas de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2016

    Quais são as últimas submissões para CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginasLIQ13

    Diversos

    Form AD03/historic register/members
    2 páginasMISC

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT para 1 More London Place London SE1 2AF em 12/01/2018

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    4 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 21/12/2017

    LRESSP

    Notificação de Ge Ese Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC02

    Retirada de uma declaração de pessoa com controlo significativo em 28/12/2017

    2 páginasPSC09

    Declaração de confirmação apresentada em 31/10/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Joseph Preston Swithenbank como diretor em 11/09/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Neil Campbell Smith como diretor em 14/06/2017

    1 páginasTM01

    Nomeação de Jonathan Lawrence John Gatt como diretor em 30/03/2017

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2016

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/10/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Segunda apresentação para a nomeação de Neil Smith como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Detalhes do diretor alterados para Joseph Preston Swithenbank em 31/08/2016

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Joseph Preston Swithenbank em 31/08/2016

    2 páginasCH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 04/03/2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of captial redemption reserve 19/02/2016
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Quem são os diretores de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretário
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Diretor
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomMaltese228824220001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretário
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secretário
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretário
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Diretor
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Diretor
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Diretor
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Diretor
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, John Robert Morton
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    Diretor
    20 Mount Avenue
    Ealing
    W5 2RG London
    EnglandBritish79328330001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Diretor
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Diretor
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Diretor
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    Bowerbank
    36 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790002
    FREDHOLM, James William
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    Diretor
    76 Staveley Road
    Chiswick
    W4 3HU London
    American33092100001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Diretor
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Diretor
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Diretor
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Diretor
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Diretor
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Diretor
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Diretor
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Diretor
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Diretor
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Diretor
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Diretor
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomUs Citizen183236480004
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    Quem são as pessoas com controle significativo de CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro1329406
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    31/10/201601/12/2017A empresa ainda não concluiu as medidas razoáveis para determinar se existe alguma pessoa que seja uma pessoa registável ou uma entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/1996
    Entregue em 30/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transações
    • 30/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 03/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 14/08/1995
    Entregue em 01/09/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    Breve descrição
    The trailers as described in the attached schedule with all accessories,components,parts......etc. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Trinity (Jersey) Limited
    Transações
    • 01/09/1995Registro de uma garantia (395)
    • 30/05/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 15/03/1994
    Entregue em 21/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13TH february 1994) on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transações
    • 21/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 30/09/1988
    Entregue em 19/10/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the first agreements of various dates
    Breve descrição
    All the company's right title & interest in the monies then or thereafterpayable to the company by the sub-leases pursuant to the terms of the sub-lease agreements.
    Pessoas com direito
    • Mdfc Industrial Finance Limtied.
    Transações
    • 19/10/1988Registro de uma garantia
    • 22/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 21/07/1988
    Entregue em 11/08/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descrição
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sub lease agreements (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    Transações
    • 11/08/1988Registro de uma garantia
    • 19/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 28/06/1988
    Entregue em 18/07/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of the first agreements and under the terms of the c harge.
    Breve descrição
    All the company's right title and interest in the monies payable to the company by the sub-lessees pursuant to the sublease agreements (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Ball Leasing Limited.
    Transações
    • 18/07/1988Registro de uma garantia
    • 22/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/03/1988
    Entregue em 07/04/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 3 badminton court church street amersham buckinghamshire title no. Bm 86544.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 07/04/1988Registro de uma garantia
    • 22/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 22/02/1988
    Entregue em 25/02/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms or by virtue of all conditional sale, hire purchase leas ing and/or bailment contracts under the terms of the charge
    Breve descrição
    All the company's rights title and interest in and to all agreements entered into or to be entered into by the company with third parties (see form 395 for full details).
    Pessoas com direito
    • Security Pacific Eurofinance Inc
    Transações
    • 25/02/1988Registro de uma garantia
    • 22/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/02/1988
    Entregue em 25/02/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents of even date
    Breve descrição
    Floating charge all its undertaking and all property and assets present and future.
    Pessoas com direito
    • Security Pacific Eurofinance, Inc.
    Transações
    • 25/02/1988Registro de uma garantia
    • 07/10/1993Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 23/12/1987
    Entregue em 12/01/1988
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement and under the terms of the charge
    Breve descrição
    Any agreement entered into whether before on or after the date hereof b etween the company and a person to whom the company lets or agrees to let goods. (For full details see form 395).
    Pessoas com direito
    • Midland Mortgage Leasing Limited
    Transações
    • 12/01/1988Registro de uma garantia
    • 22/06/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    21/12/2017Início da liquidação
    10/04/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profissional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0