THE COLONY CLUB LIMITED

THE COLONY CLUB LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Declarações de pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE COLONY CLUB LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00990697
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE COLONY CLUB LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica THE COLONY CLUB LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE COLONY CLUB LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INTERNATIONAL SPORTING CLUB (LONDON) LIMITED01/10/197001/10/1970

    Quais são as últimas contas de THE COLONY CLUB LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para THE COLONY CLUB LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Genting Club Star City Watson Road Birmingham B7 5SA para One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH em 09/10/2018

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 18/09/2018

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 23/09/2018 com atualizações

    5 páginasCS01

    Declaração de confirmação apresentada em 23/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    1 páginasAA

    Notificação de Capital Casinos Group Limited como pessoa com controlo significativo em 07/08/2017

    2 páginasPSC02

    Retirada de uma declaração de pessoa com controlo significativo em 07/08/2017

    2 páginasPSC09

    Declaração de confirmação apresentada em 23/09/2016 com atualizações

    6 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    1 páginasAA

    Nomeação de Mr James Axelby como diretor em 13/07/2016

    2 páginasAP01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Peter Malcolm Brooks em 24/05/2016

    2 páginasCH01

    Nomeação de Paul Stewart Willcock como diretor em 23/03/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Richard Robert Salmond como diretor em 23/12/2015

    1 páginasTM01

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Resoluções

    Resolutions
    27 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 21/09/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital19/10/2015

    Estado do capital em 19/10/2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    1 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Elizabeth Jill Tarn em 23/10/2014

    1 páginasCH03

    Declaração anual preparada até 21/09/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/10/2014

    Estado do capital em 20/10/2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    1 páginasAA

    Declaração anual preparada até 21/09/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital11/10/2013

    Estado do capital em 11/10/2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Quem são os diretores de THE COLONY CLUB LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    TARN, Elizabeth Jill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Secretário
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    British131467900001
    AXELBY, James
    Star City, Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club
    England
    Diretor
    Star City, Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club
    England
    United KingdomBritish210535950001
    BROOKS, Peter Malcolm
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Diretor
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    MonacoBritish84067460002
    WILLCOCK, Paul Stewart
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Diretor
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    EnglandBritish206400610001
    BARKER, Nicholas Charles Lawrence
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    Secretário
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    British10939990001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Secretário
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    British53832740002
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Secretário
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    GOULBOURNE, Sarah-Jane
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    Secretário
    36 Wynnstay Lane
    Marford
    LL12 8LG Wrexham
    Clwyd
    British64347190002
    MOORE, Gillian
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    Secretário
    13 Basil Way
    South Shields
    NE34 8UA Tyne And Waer
    British113027650001
    PEREIRA, Desmond Cajetan
    Manor Villas 161g Station Road
    Finchley Central
    N3 2SP London
    Secretário
    Manor Villas 161g Station Road
    Finchley Central
    N3 2SP London
    British108086000001
    BARKER, Nicholas Charles Lawrence
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Inshala Hilfield Lane
    Aldenham
    WD2 8AJ Watford
    Hertfordshire
    British10939990001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Diretor
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Diretor
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    United KingdomBritish53832740002
    CHILD, Colin Charles
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    Diretor
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    EnglandBritish125146440001
    DUNKLEY, John David
    29 Burnett Park
    CM19 4SD Harlow
    Essex
    Diretor
    29 Burnett Park
    CM19 4SD Harlow
    Essex
    British24899280001
    GRAY, David William
    15 Huson Close
    NW3 3JW London
    Diretor
    15 Huson Close
    NW3 3JW London
    EnglandBritish78691870001
    HEARN, Alan John
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British13648200003
    HOSKINS, Michael
    83 Nelmes Crescent
    RM11 2PR Hornchurch
    Essex
    Diretor
    83 Nelmes Crescent
    RM11 2PR Hornchurch
    Essex
    EnglandBritish55577460001
    LOWRY, Thomas Allen
    Homewood
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    Diretor
    Homewood
    Smithy Lane Mouldsworth
    CH3 8AR Chester
    EnglandBritish34909450002
    MCNALLY, Peter
    Silver Lining
    Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Silver Lining
    Brock Way
    GU25 4SD Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritish24036040001
    NESBITT, Garry
    5 Frognal Way
    Hampstead
    NW3 6XE London
    Diretor
    5 Frognal Way
    Hampstead
    NW3 6XE London
    British10940020001
    PERRIN, Nicholas John
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    Diretor
    Henley Road
    B95 5NN Ullenhall
    Treboro House
    Warwickshire
    EnglandBritish174660810001
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Diretor
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    RAHA, Maryse
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    Diretor
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    French24036050001
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Diretor
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritish62615300004
    RIDDY, Alan Michael
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    Diretor
    The Willows
    Well Lane, Mollington
    CH1 6LD Chester
    Cheshire
    EnglandBritish62615300004
    SALMOND, Richard Robert
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    Diretor
    Star City
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Circus Casino
    West Midlands
    England
    EnglandBritish164973490001
    STEINBERG, Leonard, Lord
    20 Carrwood
    Halebarns
    WA15 0EE Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    20 Carrwood
    Halebarns
    WA15 0EE Altrincham
    Cheshire
    British35686260002
    WIPER, Robert
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    Diretor
    The Hollow
    Moggie Lane
    SK10 4NY Adlington
    Cheshire
    United KingdomBritish73690420002
    WIPER, Robert
    Pelham Cottage
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Cheshire
    Diretor
    Pelham Cottage
    Brookledge Lane
    SK10 4JU Adlington
    Cheshire
    British73690420001

    Quem são as pessoas com controle significativo de THE COLONY CLUB LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club Star City
    England
    07/08/2017
    Watson Road
    B7 5SA Birmingham
    Genting Club Star City
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro02321709
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para THE COLONY CLUB LIMITED?

    Declarações de pessoas com controle significativo
    Notificado emCessado emDeclaração
    23/09/201607/08/2017A empresa ainda não concluiu as medidas razoáveis para determinar se existe alguma pessoa que seja uma pessoa registável ou uma entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

    THE COLONY CLUB LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Supplemental guarantee and debenture
    Criado em 24/12/1997
    Entregue em 08/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of capital corporation (holdings) limited and/or crockfords club limited and/or the company to midland bank PLC under the midland overdraft facility (as defined) and of cromwell sporting enterprises limited to national westminster bank PLC under the natwest overdraft facility (as defined) and of each obligor (as defined) due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined) and of each obligor due or to become due to the chargee and/or the banks (as defined) or any of them under any other financing documents (as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Agent")
    Transações
    • 08/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 16/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture
    Criado em 18/12/1995
    Entregue em 04/01/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present or future obligations and liabilities of the company to the chargees pursuant to the terms of the 364-day facility the security and financing documents (as defined) and/or this supplemental debenture
    Breve descrição
    All the property (if any ) specified in the first schedule to the original guarantee and debenture together with all buildings and fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for the Revolving Credit Banks and the Overdraft Bank (Asdefined)
    Transações
    • 04/01/1996Registro de uma garantia (395)
    • 16/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 01/08/1995
    Entregue em 15/08/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from crockfords (holdings) limited to the chargee and/or the revolving credit banks (or any of them) under the facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from crockfords (holdings) limited and/or crockfords club limited to the overdraft bank under the overdraft facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and/or the banks (or any of them) under the security document(s) or any other financing document(s) (as defined) to which it is a party
    Breve descrição
    An underlease dated 1994 and relating to casino premises at 18-19 old park land and 24 hertford street london W1 t/n NGL726210, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and for the Revolving Credit Banks and the Overdraft Bank (As Defined)
    Transações
    • 15/08/1995Registro de uma garantia (395)
    • 16/02/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 01/03/1994
    Entregue em 11/03/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The William Hill Group Limited
    Transações
    • 11/03/1994Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 30/03/1992
    Entregue em 14/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture.
    Breve descrição
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The William Hill Group Limited
    Transações
    • 14/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 27/03/1992
    Entregue em 13/04/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 13/04/1992Registro de uma garantia (395)
    • 12/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 11/11/1991
    Entregue em 28/11/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all of the other companies named therein to the chargee under the facility agreement dated 11TH november 1991
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 28/11/1991Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 01/07/1991
    Entregue em 18/07/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from thebrent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1ST july 1991
    Breve descrição
    See doc M150 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 18/07/1991Registro de uma garantia (395)
    • 29/09/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 28/03/1991
    Entregue em 17/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of this deed to the chargee.
    Breve descrição
    (See doc M140 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders as Defined)
    Transações
    • 17/04/1991Registro de uma garantia
    • 12/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 28/03/1991
    Entregue em 16/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from brent walker limited under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed to the chargee.
    Breve descrição
    (See doc M171 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 16/04/1991Registro de uma garantia
    • 12/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 28/03/1991
    Entregue em 16/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC under the terms of the stand by facility agreement dated 15/11/90 and this deed to the chargee.
    Breve descrição
    (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 16/04/1991Registro de uma garantia
    • 29/09/1992Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Criado em 28/03/1991
    Entregue em 16/04/1991
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of the facility agreement dated 28/3/91 and this deed th the chargee.
    Breve descrição
    (See doc M125 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 16/04/1991Registro de uma garantia
    • 12/05/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    THE COLONY CLUB LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    18/09/2018Início da liquidação
    04/09/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profissional
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicholas James Timpson
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profissional
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0