CURTIS COACHES LIMITED

CURTIS COACHES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCURTIS COACHES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00991316
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CURTIS COACHES LIMITED?

    • Outro transporte terrestre de passageiros urbano, suburbano ou metropolitano (não metro, metropolitano ou sistemas similares) (49319) / Transportes e armazenagem

    Onde fica CURTIS COACHES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de CURTIS COACHES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para CURTIS COACHES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginas4.71

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP em 14/09/2012

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 04/09/2012

    LRESSP

    Término da nomeação de John Greaves como diretor em 28/08/2012

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Nigel Paul Featham como diretor em 28/08/2012

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    6 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Ms Elizabeth Anne Thorpe em 26/05/2012

    1 páginasCH03

    Declaração anual preparada até 18/04/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/04/2012

    Estado do capital em 23/04/2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    6 páginasAA

    Nomeação de Kenneth Mcintyre Carlaw como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Turner como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Nigel Paul Featham como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jonathan May como diretor

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 18/04/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Paul Turner em 18/04/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Jonathan Paul May em 18/04/2011

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para John Greaves em 18/04/2011

    2 páginasCH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 18/04/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do secretário alterados para Ms Elizabeth Anne Thorpe em 18/04/2010

    1 páginasCH03

    Contas preparadas até 31/12/2008

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Quem são os diretores de CURTIS COACHES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Secretário
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Diretor
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Secretary161250030001
    CAMPBELL, David Gerard
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretário
    47 Ridgely Drive
    Ponteland
    NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8159840001
    HINDMARSH, Patricia Gail
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Secretário
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    BritishAccountant Director40429750001
    JONES, Michael Adrian
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    Secretário
    5 Sandycroft
    Warsash
    SO31 9AA Southampton
    Hampshire
    British36134870001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretário
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretário
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    ARMSTRONG, Robert William
    West Cairn House
    Dalton
    NE18 0AB Newcastle Upon Tyne
    Diretor
    West Cairn House
    Dalton
    NE18 0AB Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director2197270001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    DUNN, Edward
    2 Hill Park
    Ponteland
    NE20 9RX Newcastle Upon Tyne
    Diretor
    2 Hill Park
    Ponteland
    NE20 9RX Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishCompany Director5098870001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Diretor
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritishManging Director161124990001
    FICKLING, John Matthew
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Diretor
    62 Gainsborough Close
    NE25 9XB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishEngineering Director40818470001
    GREAVES, John
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Diretor
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishDirector40433200001
    HINDMARSH, Patricia Gail
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Diretor
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    BritishAccountant Director40429750001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector77984700001
    KENNAN, Anthony Denis
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Diretor
    13 The Poplars
    Gosforth
    NE3 4AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCommercial Director8159860001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Diretor
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector6874440001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Diretor
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Diretor
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishDirector125675730002
    MONAGHAN, David Bell
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Diretor
    43 Well Ridge Close
    Redhouse Farm
    NE25 9PN Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishManaging Director35862500001
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Diretor
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Diretor
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Diretor
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishChartered Secretary48937720001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Diretor
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    BritishDirector2719600006

    CURTIS COACHES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Criado em 15/08/1994
    Entregue em 31/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descrição
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 31/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 06/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 11/08/1994
    Entregue em 26/08/1994
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transações
    • 26/08/1994Registro de uma garantia (395)
    • 01/05/1998Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 13/07/1990
    Entregue em 23/07/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys due or to become due from praidmutural fleet management limited and/or any of the other companies named to the chargee under the terms of this charge and pursuant to a loan agreement of even date
    Breve descrição
    The property specified on form M395, reg 230. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Pessoas com direito
    • Dresdner Bank A.G.
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for Itself
    Transações
    • 23/07/1990Registro de uma garantia
    • 06/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 13/07/1990
    Entregue em 23/07/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property specified on form M395, reg M257. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chartered Bank
    Transações
    • 23/07/1990Registro de uma garantia
    • 06/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/03/1990
    Entregue em 06/04/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Standard Chatered Bank
    Transações
    • 06/04/1990Registro de uma garantia
    • 06/07/1995Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Omnibus letter of set-off
    Criado em 03/06/1986
    Entregue em 11/06/1986
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 11/06/1986Registro de uma garantia
    • 14/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 21/07/1976
    Entregue em 27/07/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H. garage and premises at weelslade rd, dudley, northumberland.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 27/07/1971Registro de uma garantia
    • 14/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 15/06/1971
    Entregue em 02/07/1971
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £5,000
    Breve descrição
    F/H. garage and premises at weeslade rd, dudley, northumberland.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 02/07/1971Registro de uma garantia
    • 14/05/1994Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CURTIS COACHES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    08/04/2013Data de dissolução
    04/09/2012Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profissional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profissional
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0