RFB OLD CO LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRFB OLD CO LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 00998670
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RFB OLD CO LIMITED?

    • Fabricação de outros produtos alimentícios n.e.c. (10890) / Indústrias transformadoras

    Onde fica RFB OLD CO LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RFB OLD CO LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    R.F. BROOKES LIMITED25/01/198225/01/1982
    R.F.BROOKES(LEICESTER)LIMITED01/01/197101/01/1971

    Quais são as últimas contas de RFB OLD CO LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para RFB OLD CO LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Andrew John Mcdonald como diretor em 23/05/2018

    1 páginasTM01

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    1 páginasGAZ2

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória

    1 páginasGAZ1

    Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 11/11/2016

    1 páginasTM01

    Restauração por ordem judicial

    8 páginasAC92

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaração anual preparada até 30/09/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital23/10/2013

    Estado do capital em 23/10/2013

    • Capital: GBP 15,000,000
    SH01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 30/09/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    7 páginasAA

    Nomeação de Emmett Mcevoy como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Antony Smith como diretor

    1 páginasTM01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed R.F. brookes LIMITED\certificate issued on 05/12/11
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name05/12/2011

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15
    change-of-name05/12/2011

    Alteração do nome" por resolução

    NM01

    Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Suzanne Wise como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Declaração dos objetos da sociedade

    2 páginasCC04

    Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade

    2 páginasCC02

    Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/08/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Quem são os diretores de RFB OLD CO LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretário
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretário
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Adam David
    Braeside House
    NP25 4JG Mitchel Troy Common
    Monmouthshire
    Diretor
    Braeside House
    NP25 4JG Mitchel Troy Common
    Monmouthshire
    United KingdomBritish87570630001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    COLES, Philip David
    Barn End Cashes Farm
    Elmbridge Lane Elmbridge
    WR9 0NQ Droitwich
    Worcestershire
    Diretor
    Barn End Cashes Farm
    Elmbridge Lane Elmbridge
    WR9 0NQ Droitwich
    Worcestershire
    EnglandBritish105679940001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Diretor
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Diretor
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    HARGREAVES, Stephen John
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Diretor
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Great BritainBritish99437380001
    HODSON, Mark Anthony
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    Diretor
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish142364940001
    HUMPHREY, Paul
    16 Shelley Road
    HP11 2UP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    16 Shelley Road
    HP11 2UP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British86203530001
    JACKSON, Timothy Mark
    5 Palace Road
    Llandaf
    CF5 2AF Cardiff
    Diretor
    5 Palace Road
    Llandaf
    CF5 2AF Cardiff
    British54757060001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Diretor
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Diretor
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    108 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    108 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EW Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish87359710001
    PICKERING, Alistair Neil
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    Diretor
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    United KingdomBritish83785410002
    QUICK, Nigel Robert
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    Diretor
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    British36629900001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Diretor
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Diretor
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SIMMONS, Alex Thomas
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish105865430001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001

    RFB OLD CO LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 26/07/2004
    Entregue em 06/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Wern industrial estate rogerstone newport gwent f/h t/n's WA717549 WA77355 WA535808. Magna road south wigston leicester f/h t/n LT211256. Rogerstone park newport gwent f/h t/n WA859509. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 06/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Criado em 11/09/2000
    Entregue em 23/09/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transações
    • 23/09/2000Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0