RFB OLD CO LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | RFB OLD CO LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 00998670 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RFB OLD CO LIMITED?
- Fabricação de outros produtos alimentícios n.e.c. (10890) / Indústrias transformadoras
Onde fica RFB OLD CO LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RFB OLD CO LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| R.F. BROOKES LIMITED | 25/01/1982 | 25/01/1982 |
| R.F.BROOKES(LEICESTER)LIMITED | 01/01/1971 | 01/01/1971 |
Quais são as últimas contas de RFB OLD CO LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2011 |
Quais são as últimas submissões para RFB OLD CO LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Andrew John Mcdonald como diretor em 23/05/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Restauração por ordem judicial | 3 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 11/11/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Restauração por ordem judicial | 8 páginas | AC92 | ||||||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/09/2013 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/09/2012 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nomeação de Emmett Mcevoy como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Antony Smith como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed R.F. brookes LIMITED\certificate issued on 05/12/11 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Mcdonald como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Suzanne Wise como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaração dos objetos da sociedade | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Aviso de remoção da restrição sobre os estatutos da sociedade | 2 páginas | CC02 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 30/09/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/08/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de RFB OLD CO LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretário | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Secretário | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Secretário | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretário | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secretário | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Secretário | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Diretor | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| CLARKE, Adam David | Diretor | Braeside House NP25 4JG Mitchel Troy Common Monmouthshire | United Kingdom | British | 87570630001 | |||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Diretor | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| COLES, Philip David | Diretor | Barn End Cashes Farm Elmbridge Lane Elmbridge WR9 0NQ Droitwich Worcestershire | England | British | 105679940001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Diretor | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Diretor | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| HARGREAVES, Stephen John | Diretor | Stable House Smeeton Road LE8 0QT Saddington Leicestershire | Great Britain | British | 99437380001 | |||||
| HODSON, Mark Anthony | Diretor | Orchard Barn Bulby PE10 0RU Bourne Lincolnshire | England | British | 142364940001 | |||||
| HUMPHREY, Paul | Diretor | 16 Shelley Road HP11 2UP High Wycombe Buckinghamshire | British | 86203530001 | ||||||
| JACKSON, Timothy Mark | Diretor | 5 Palace Road Llandaf CF5 2AF Cardiff | British | 54757060001 | ||||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Diretor | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Diretor | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Diretor | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCMAHON, Ian Reid | Diretor | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Diretor | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| OAKLEY, Christopher Richard | Diretor | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | England | British | 124625030001 | |||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Diretor | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 | ||||||
| PEELER, Andrew Michael | Diretor | 108 Ellesborough Road Wendover HP22 6EW Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| PICKERING, Alistair Neil | Diretor | 13 Upper Cranbrook Road Redland BS6 7UW Bristol | United Kingdom | British | 83785410002 | |||||
| QUICK, Nigel Robert | Diretor | Autumn Cottage 8 Gladstone Street LE8 0HL Kibworth Beauchamp Leicestershire | British | 36629900001 | ||||||
| RUDDICK, Ian William | Diretor | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Diretor | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | United Kingdom | British | 42065200002 | |||||
| SIMMONS, Alex Thomas | Diretor | 39 Pedmore Lane Pedmore DY9 0SY Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 105865430001 | |||||
| SMITH, Antony David | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | United Kingdom | British | 147725160001 |
RFB OLD CO LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 26/07/2004 Entregue em 06/08/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Wern industrial estate rogerstone newport gwent f/h t/n's WA717549 WA77355 WA535808. Magna road south wigston leicester f/h t/n LT211256. Rogerstone park newport gwent f/h t/n WA859509. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Criado em 11/09/2000 Entregue em 23/09/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0