AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED

AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaAGBL OPCO REALISATIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01016191
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    • Venda a retalho de vestuário em estabelecimentos especializados (47710) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
    • Venda a retalho de calçado em estabelecimentos especializados (47721) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED19/06/199819/06/1998
    GREENHAWK LIMITED17/09/199717/09/1997
    DORSUB (TMR) LIMITED19/05/199419/05/1994
    TOP MAN RETAIL LIMITED23/02/199023/02/1990
    TOP BOY LIMITED31/12/197831/12/1978
    HAND OF BURTON LIMITED30/06/197130/06/1971

    Quais são as últimas contas de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até01/09/2018

    Quais são as últimas submissões para AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Aviso de mudança da administração para dissolução

    28 páginasAM23

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN para C/O Teneo Finacial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN em 22/11/2022

    2 páginasAD01

    Relatório de progresso do administrador

    33 páginasAM10

    Relatório de progresso do administrador

    23 páginasAM10

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed arcadia group brands LIMITED\certificate issued on 07/12/21
    2 páginasCERTNM
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Aviso de extensão do período da administração

    4 páginasAM19

    Endereço do domicílio registado alterado de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN para C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN em 06/09/2021

    2 páginasAD01

    Relatório de progresso do administrador

    26 páginasAM10

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ para 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN em 28/06/2021

    2 páginasAD01

    Resultado da reunião dos credores

    44 páginasAM07

    Declaração de negócios com formulário AM02SOA/AM02SOC

    12 páginasAM02

    Declaração de proposta do administrador

    43 páginasAM03

    Endereço do domicílio registado alterado de Colegrave House 70 Berners Street London W1T 3NL para C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ em 14/12/2020

    2 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    4 páginasAM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Término da nomeação de Paul Stephen Price como diretor em 13/12/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Michelle Jane Gammon como secretário em 21/11/2019

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 01/09/2018

    19 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2019 com atualizações

    5 páginasCS01

    Término da nomeação de Jonathan Sokoloff como diretor em 22/03/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Adam Thomas Levyn como diretor em 22/03/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Adam Thomas Levyn como diretor em 31/12/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de James Halper como diretor em 31/12/2018

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FOREY, Siobhan
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    United KingdomBritish111977210002
    GRABINER, Ian Michael
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    ScotlandBritish63235540002
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited
    West Midlands
    Diretor
    156 Great Charles Street Queensway
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    C/O Teneo Finacial Advisory Limited
    West Midlands
    United KingdomBritish103945640001
    BERGAMIN, Jayabaduri
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    Secretário
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    British116935080001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Secretário
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    COX, Michelle Hazel
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    Secretário
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    British104461530003
    GAMMON, Michelle Jane
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Secretário
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    221297650001
    GOLDMAN, Adam Alexander
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Secretário
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    British192403200001
    HICKS, Beverley
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    Secretário
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    British92357410001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretário
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretário
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretário
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    PREMI, Gurpal
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    Secretário
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    British180475620001
    RODIE, Kimberly Donna
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Secretário
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    148647910001
    RODIE, Kimberly Donna
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Secretário
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Other134585610002
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretário
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secretário
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    WALDRON, Aisha Leah
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretário
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147374130001
    BATES, David John
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Diretor
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish613990001
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40354400003
    BUDGE, Paul Everard
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House 68-70
    United Kingdom
    Diretor
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House 68-70
    United Kingdom
    United KingdomBritish88851520002
    BURCHILL, Richard Leeroy
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish115568070002
    CROSSLAND, Julie Sook Hein
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    Diretor
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    EnglandBritish70464290002
    DEDOMBAL, Richard
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    Diretor
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    United KingdomBritish165695440001
    DUCKELS, Colin Peter
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish44237310004
    GERAGHTY, Mary Julia Margaret
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish125285460003
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Diretor
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritish28466260004
    HAGUE, Gillian Anne
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish99223490001
    HALPER, James
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United StatesAmerican174851860001
    HARRIS, Christopher Bryan
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    United KingdomBritish234603670001
    HEALEY, Mark Anthony
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Diretor
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    EnglandBritish77432550002
    HIND, Andrew Clive
    14 Princes Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LR London
    Diretor
    14 Princes Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LR London
    EnglandBritish113038870001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Diretor
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    HOMER, Mary Elizabeth
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Diretor
    Colegrave House
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    United KingdomBritish175056190001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Diretor
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001

    Quem são as pessoas com controle significativo de AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    06/04/2016
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00237511
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 14/12/2004
    Entregue em 23/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transações
    • 23/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 04/02/2013Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 10 september 2002
    Criado em 18/12/2002
    Entregue em 23/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each charging company to the security trustee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forthe Security Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transações
    • 23/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 18/01/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    AGBL OPCO REALISATIONS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/11/2020Início da administração
    08/12/2022Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Matthew David Smith
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profissional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Gavin Maher
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profissional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Daniel Francis Butters
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profissional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0