ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01065384 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
- Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| FTMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED | 01/03/1995 | 01/03/1995 |
| FMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED | 14/08/1992 | 14/08/1992 |
| FORWARD TRUST CAR LEASING LIMITED | 08/01/1992 | 08/01/1992 |
| ASSETPURCHASE LIMITED | 18/08/1986 | 18/08/1986 |
| COLSHIRE LIMITED | 11/08/1972 | 11/08/1972 |
Quais são as últimas contas de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de solvência | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 8 Canada Square London E14 5HQ para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 31/12/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Okechukwu Uwakwe em 17/07/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr. James Richard Hughes como secretário em 15/08/2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Molly Ranger como secretário em 15/08/2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Crispin Robert John Irvin em 07/02/2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 7 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 9 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 8 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 6 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Miss Molly Ranger como secretário em 22/03/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Romana Lewis como secretário em 08/12/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Okechukwu Uwakwe como diretor em 12/09/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Segunda apresentação para a nomeação de Crispin Robert John Irvin como administrador | 6 páginas | RP04AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de John Richard Kent como diretor em 31/05/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGHES, James Richard, Mr. | Secretário | E14 5HQ London 8 Canada Square United Kingdom | 261711070001 | |||||||
| IRVIN, Crispin Robert John | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 228671160002 | |||||
| LONG, Simon Einar | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| UWAKWE, Okechukwu | Diretor | 8 Canada Square E14 5HQ London Level 2 United Kingdom | England | Irish | 137525250002 | |||||
| BAYER, George William | Secretário | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 188917800001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092040001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Secretário | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| LEWIS, Romana | Secretário | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E14 5HQ London, Greater London 8 England England | 198529210001 | |||||||
| MCKENZIE, John Hume | Secretário | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Secretário | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Secretário | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Secretário | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Secretário | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| RANGER, Molly | Secretário | E14 5HQ London 8 Canada Square United Kingdom | 245613190001 | |||||||
| READ, Alice | Secretário | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209410001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154912590001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967370001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| BARKER, Fiona Ann | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| CAVANNA, David John | Diretor | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| EVANS, Geoffrey William | Diretor | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Diretor | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Diretor | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Diretor | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| KENT, John Richard | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Diretor | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| MEAD, David Harry | Diretor | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 | |||||
| PICKEN, Graham Edward | Diretor | 60 Church Road Aspley Heath Woburn Sands MK17 8TA Milton Keynes | British | 144947830001 | ||||||
| QUINN, Noel Paul | Diretor | 10 Besford Grove Shirley B90 4YU Solihull West Midlands | British | 72093050001 | ||||||
| SENIOR, Carl Thomas | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 165728830001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Asset Finance (Uk) Limited | 26/10/2016 | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A first priority honh kong ship mortgage | Criado em 30/05/2007 Entregue em 20/06/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The 8,063 teu container vellse with official number hk-1900 names "oocl southampton". | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Hong kong ship mortgage | Criado em 08/01/2007 Entregue em 15/01/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The 99,705.6 dwt vessel with hull number 1569 registered at the hong kong shipping registry with official number hk-1806 under the name oocl europe. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of covenant | Criado em 25/01/2005 Entregue em 27/01/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1570 registered or to be registered under the hong kong flag and includes any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of covenant | Criado em 25/01/2005 Entregue em 27/01/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1569 registered or to be registered under the hong kong flag and including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A hong kong ship mortgage | Criado em 11/05/2004 Entregue em 17/05/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The vessel named oocl ningbo registered in the hong kong register of ships with official number hk-1200 (the vessel). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Second deed of covenant | Criado em 15/04/2004 Entregue em 19/04/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1427 and to be named oocl ningbo and registered or to be registered under the hong kong flag including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Second deed of covenant | Criado em 15/04/2004 Entregue em 19/04/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The 99,500 dwt container vessel named oocl qingdao and rgeistered under the hong kong flag with official number hk-1199 and call sign VRZL2 including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Hong kong ship mortgage | Criado em 07/04/2004 Entregue em 14/04/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The vessel named oocl qingdao registered in the hong kong register of ships with official number hk-1199. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0