ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01065384
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    • Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    FTMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED01/03/199501/03/1995
    FMF LEASING DECEMBER (D) LIMITED14/08/199214/08/1992
    FORWARD TRUST CAR LEASING LIMITED08/01/199208/01/1992
    ASSETPURCHASE LIMITED18/08/198618/08/1986
    COLSHIRE LIMITED11/08/197211/08/1972

    Quais são as últimas contas de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 13/12/2019

    LRESSP

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Endereço do domicílio registado alterado de 8 Canada Square London E14 5HQ para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 31/12/2019

    2 páginasAD01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Okechukwu Uwakwe em 17/07/2019

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    22 páginasAA

    Nomeação de Mr. James Richard Hughes como secretário em 15/08/2019

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Molly Ranger como secretário em 15/08/2019

    1 páginasTM02

    Detalhes do diretor alterados para Crispin Robert John Irvin em 07/02/2019

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 7

    2 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 9

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 8

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 6

    2 páginasMR04

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    30 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Miss Molly Ranger como secretário em 22/03/2018

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Romana Lewis como secretário em 08/12/2017

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr Okechukwu Uwakwe como diretor em 12/09/2017

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    29 páginasAA

    Segunda apresentação para a nomeação de Crispin Robert John Irvin como administrador

    6 páginasRP04AP01

    Término da nomeação de John Richard Kent como diretor em 31/05/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/05/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Quem são os diretores de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HUGHES, James Richard, Mr.
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    Secretário
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    261711070001
    IRVIN, Crispin Robert John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish228671160002
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    UWAKWE, Okechukwu
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Level 2
    United Kingdom
    Diretor
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Level 2
    United Kingdom
    EnglandIrish137525250002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Secretário
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    188917800001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092040001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Secretário
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Secretário
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198529210001
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Secretário
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Secretário
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Secretário
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Secretário
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Secretário
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    RANGER, Molly
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    Secretário
    E14 5HQ London
    8 Canada Square
    United Kingdom
    245613190001
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Secretário
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209410001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154912590001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Secretário
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967370001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Diretor
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Diretor
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Diretor
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Diretor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Diretor
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Diretor
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Diretor
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Diretor
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    SENIOR, Carl Thomas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Diretor
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish165728830001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26/10/2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro229341
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A first priority honh kong ship mortgage
    Criado em 30/05/2007
    Entregue em 20/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The 8,063 teu container vellse with official number hk-1900 names "oocl southampton".
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 20/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Criado em 08/01/2007
    Entregue em 15/01/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The 99,705.6 dwt vessel with hull number 1569 registered at the hong kong shipping registry with official number hk-1806 under the name oocl europe. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K) Limited
    Transações
    • 15/01/2007Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenant
    Criado em 25/01/2005
    Entregue em 27/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1570 registered or to be registered under the hong kong flag and includes any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 27/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 05/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of covenant
    Criado em 25/01/2005
    Entregue em 27/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    A 99,624 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1569 registered or to be registered under the hong kong flag and including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 27/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A hong kong ship mortgage
    Criado em 11/05/2004
    Entregue em 17/05/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The vessel named oocl ningbo registered in the hong kong register of ships with official number hk-1200 (the vessel).
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 17/05/2004Registro de uma garantia (395)
    • 22/09/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Second deed of covenant
    Criado em 15/04/2004
    Entregue em 19/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The 99,500 dwt (metric) container vessel known during construction as hull no. 1427 and to be named oocl ningbo and registered or to be registered under the hong kong flag including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 19/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    • 22/09/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Second deed of covenant
    Criado em 15/04/2004
    Entregue em 19/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The 99,500 dwt container vessel named oocl qingdao and rgeistered under the hong kong flag with official number hk-1199 and call sign VRZL2 including any share or interest in that vessel and its engines machinery boats tackle outfit spare gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 19/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 21/05/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Hong kong ship mortgage
    Criado em 07/04/2004
    Entregue em 14/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The vessel named oocl qingdao registered in the hong kong register of ships with official number hk-1199.
    Pessoas com direito
    • Orient Overseas Container Line (U.K.) Limited
    Transações
    • 14/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)

    ASSETFINANCE DECEMBER (M) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    13/12/2019Início da liquidação
    12/05/2021Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profissional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Profissional
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0