HAWKINS PLANT

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaHAWKINS PLANT
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada de responsabilidade ilimitada
    Número da empresa 01065554
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de HAWKINS PLANT?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica HAWKINS PLANT?

    Endereço do escritório registrado
    The Grange 2 Aston Street
    Wem
    SY4 5AY Shrewsbury
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de HAWKINS PLANT?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HAWKINS PLANT HIRE LIMITED02/04/198402/04/1984
    CHARLES HAWKINS & SONS(CONTRACTORS)LIMITED11/08/197211/08/1972

    Quais são as últimas contas de HAWKINS PLANT?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2020

    Quais são as últimas submissões para HAWKINS PLANT?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01
    ABDZZT2Q

    Término da nomeação de Alan Arthur Nixon como secretário em 06/12/2021

    1 páginasTM02
    XAIQPJ5T

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01
    XAIQPIOQ

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020

    6 páginasAA
    AACUBHG2

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X9YDRTX5

    Término da nomeação de Alan Arthur Nixon como diretor em 15/02/2021

    1 páginasTM01
    X9YDQAWH

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019

    6 páginasAA
    A95C33JC

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X8J521KR

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018

    6 páginasAA
    A8DOOOII

    Endereço do domicílio registado alterado de Charleston House Cruckmoor Lane Prees Green Whitchurch Shropshire SY13 2BS para The Grange 2 Aston Street Wem Shrewsbury SY4 5AY em 04/09/2019

    1 páginasAD01
    X8DBEBMA

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X7JP4WIP

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    7 páginasAA
    X75HVWQY

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X6K4JBHN

    Contas de micro-entidade preparadas até 31/12/2016

    5 páginasAA
    A65WFWR4

    Declaração de confirmação apresentada em 27/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01
    X5KOM9UP

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    6 páginasAA
    A5CS11BD

    Declaração anual preparada até 27/11/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital01/12/2015

    Estado do capital em 01/12/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X4LBC8KA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA
    A41IJBJS

    Declaração anual preparada até 27/11/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/12/2014

    Estado do capital em 04/12/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X3LZX60Z

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA
    A3FLXLQJ

    Declaração anual preparada até 27/11/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/12/2013

    Estado do capital em 10/12/2013

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X2MWSHMJ

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    6 páginasAA
    A28Y5029

    Declaração anual preparada até 27/11/2012 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    X1MP61SQ

    Quem são os diretores de HAWKINS PLANT?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HAWKINS, Janette Helen
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Diretor
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    EnglandBritishDirector37309220001
    BURNS, Christopher
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    Secretário
    5 Richards Close
    Wootton Bassett
    SN4 7LE Swindon
    Wiltshire
    IrishAccountant66007600001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Secretário
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    BritishDirector67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Secretário
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    British2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Secretário
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishFinance Director5179100002
    STOTT, Christopher
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    Secretário
    5 Grange Park
    St. Arvans
    NP16 6EA Chepstow
    BritishAccountant84131830001
    WYCHERLEY, Sian Mair
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    Secretário
    Hillside
    The Graig
    NP1 7FA Cwmcarn
    Gwent
    British60690570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ATKINSON, Ralph
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    Diretor
    5 Ferndene
    BS32 9DG Bradley Stoke
    Bristol
    BritishRisk Director82227730001
    BISH, Andrew Brandon
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    Diretor
    Fairfield House
    Malmesbury Road
    SN16 9QX Minety
    Wiltshire
    United KingdomBritishFinancial Director87360330001
    BLACKBURN, Robert Paul
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    Diretor
    Willow Cottage Coalpit Lane
    Off Station Road Whittington
    SY11 4BW Oswestry
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director181188220001
    BONGARTEN, Karl James
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    Diretor
    27 Lost Mine Place
    06877 Ridgefield
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59693970001
    CAMERON, Richard Alexander
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    Diretor
    Druidstone House
    64 High Street Stanwick
    NN9 6QA Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishCompany Director16715040001
    DODDRELL, Paul Derek
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    Diretor
    177 Juniper Way
    BS32 0DP Bradley Stoke
    Bristol
    BritishChief Financial Officer74659020001
    EDWARDS, David
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    Diretor
    12 The Culvert
    BS32 8AB Bradley Stoke
    Bristol
    BritishManaging Director74658940003
    FANELLI, Tom Francis
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    Diretor
    No 4 Mendas Road Danbury 06811
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59691400001
    HAWKINS, Charles Barry Kitley
    SY4
    Diretor
    SY4
    United KingdomBritishDirector39331910001
    HAWKINS, Charles Ernest Kitley
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Diretor
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    BritishDirector2938910001
    HAWKINS, Evelyn Melrose
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    Diretor
    Belle Vue Ellesmere Road
    Wem
    SY4 5TX Shrewsbury
    Salop
    BritishDirector2938870001
    HAWKINS, Michael Edward Ernest
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    Diretor
    Grange House
    Loppington
    SY4 5SR Wem
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector188706610001
    JACOBS, Christopher
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    Diretor
    299 Seneca Place
    Westfield
    New Jersey 07090
    Usa
    AmericanChief Financial Officer47655500001
    JONES, Frank Douglas
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    Diretor
    Franklyn 10 Prescott Fields
    Baschurch
    SY4 2EL Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishPlant Manager53180400001
    LITTLES, Carolyn Sue
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    Diretor
    25 River Road
    Apt 3107
    06897 Wilton
    Connecticut
    Usa
    AmericanCompany Vice President59691910001
    MATTHEW, Jeremy
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    Diretor
    Beethovenstraat 132-3
    FOREIGN Amsterdam
    1077 Js
    The Netherlands
    British And CanadianDirector115291490001
    NIXON, Alan Arthur
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    Diretor
    The Old House
    Brown Heath
    SY12 0LB Ellesmere
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector67543830004
    OTTERBURN, Hugh Robert
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    Diretor
    28 Longford Turning
    TF9 3PF Market Drayton
    Salop
    BritishDirector2938860001
    PASS, Alan
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    Becketts 11 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishFinance Director5179100002
    SHUTT, Beverly Vincent
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    Diretor
    15 Delphside
    TF12 5EP Broseley
    Salop
    EnglishCompany Director34374060001
    SMITH, Gary John
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    Diretor
    1 Eagle Farm Close
    Myddle
    SY4 3RQ Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishService Manager24872600001
    SMITH, Peter Leslie
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    Diretor
    Grove House
    Grove Crescent, Woore
    CW3 9SX Crewe
    Cheshire
    BritishChartered Accountant88329890001
    THOMPSON, Brian
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    The Silo 4 The Greenyard
    Yardley Hastings
    NN7 1EQ Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCompany Director17395050002
    WILLIAMS, Robert Clive
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    Diretor
    Cross Keys Farm
    Brown Heath
    SY12 0LA Ellesmere
    Salop
    BritishDirector2938890001

    Quem são as pessoas com controle significativo de HAWKINS PLANT?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Aarco 287 Limited
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    06/04/2016
    Cruckmoor Lane
    Prees Green
    SY13 2BS Whitchurch
    Charleston House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalEnglish
    Local de registroEndland And Wales
    Número de registro6144291
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    HAWKINS PLANT possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating charge
    Criado em 12/12/1995
    Entregue em 20/12/1995
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 20/12/1995Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/1999Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 10/03/1993
    Entregue em 31/03/1993
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 31/03/1993Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/10/1992
    Entregue em 13/11/1992
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents (as defined therein)
    Breve descrição
    Floating charge over all assets and rights of the company present and future.
    Pessoas com direito
    • Security Pacific Eurofinance PLC
    Transações
    • 13/11/1992Registro de uma garantia (395)
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 21/09/1990
    Entregue em 03/10/1990
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The depot on the north west side of mold road buckley, clwyd title no wa 55216.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 03/10/1990Registro de uma garantia
    • 14/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Lease purchase agreement
    Criado em 29/06/1987
    Entregue em 03/07/1987
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,252,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease purchase agreement.
    Breve descrição
    All insurance policies whatsoever in respect of items of equipment (see form 395 for full details) and all the benefits thereof.
    Pessoas com direito
    • Lefac International Sa
    Transações
    • 03/07/1987Registro de uma garantia
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 02/04/1984
    Entregue em 19/04/1984
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 19/04/1984Registro de uma garantia
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 01/08/1983
    Entregue em 08/08/1983
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or charles hawkins & sons (tractors and machinery) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 08/08/1983Registro de uma garantia
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 01/02/1982
    Entregue em 09/02/1982
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land at loppington 1.713 acres shropshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 09/02/1982Registro de uma garantia
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 23/10/1981
    Entregue em 29/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H grange farm loppington wem shropshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/10/1981Registro de uma garantia
    • 14/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 23/10/1981
    Entregue em 29/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H the old cheese store ellesmere road wem shropshire.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/10/1981Registro de uma garantia
    • 10/12/1991Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 09/10/1981
    Entregue em 19/10/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Together with all buildings and trade fixtures including fixed p & m thereon.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 19/10/1981Registro de uma garantia
    • 12/01/1996Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 11/05/1981
    Entregue em 18/05/1981
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land at loppington shropshire being no 166 on the O.S. map for the area.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 18/05/1981Registro de uma garantia
    Mortgage
    Criado em 17/09/1980
    Entregue em 25/09/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H premises being grange farm, loppington, wem, shropshire together with all fixtures.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 25/09/1980Registro de uma garantia
    Irrevocable authority to messrs graham withers & co evidencing equitable assignment of property
    Criado em 12/05/1980
    Entregue em 19/05/1980
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Freehold land and premises being grange farm loppington, wem, shropshire together with all fixtures whatsoever.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 19/05/1980Registro de uma garantia

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0