CONEMSCO LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CONEMSCO LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 01084374 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CONEMSCO LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica CONEMSCO LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Units 15 & 16 Blackfriars Court Excalibur Road Beacon Park NR31 7RQ Gorleston Great Yarmouth United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de CONEMSCO LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para CONEMSCO LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 08/07/2022
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Steven Mclean como diretor em 07/02/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Unit 8B St Leger Drive Newmarket Suffolk CB8 7DT United Kingdom para Units 15 & 16 Blackfriars Court Excalibur Road Beacon Park Gorleston Great Yarmouth NR31 7RQ em 02/12/2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/12/2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Alan Freeland como secretário em 25/05/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Ethel Victoria Speirs como secretário em 25/05/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mrs Ethel Victoria Speirs em 20/03/2018 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Steven Mclean em 20/03/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Alan Freeland em 20/03/2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Retirada de uma declaração de pessoa com controlo significativo em 14/02/2018 | 2 páginas | PSC09 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de CONEMSCO LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREELAND, Alan | Secretário | Altens AB12 3HT Aberdeen Peterseat Drive United Kingdom | 247129590001 | |||||||
| FREELAND, Alan | Diretor | Altens AB12 3HT Aberdeen Peterseat Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 196008270001 | |||||
| BOWLCOTT, Robert John | Secretário | Broadfield Court Barn Bishops Frome WR6 5BP Worcester Worcestershire | British | 122447600001 | ||||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Secretário | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| CHIVERS, Susan | Secretário | 75 Worcester Gardens SL1 2QB Slough Berkshire | British | 24686130002 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Secretário | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 170641660001 | |||||||
| HENDRY, Eric George | Secretário | School Road AB1 0WB Newmachar 19 Aberdeenshire United Kingdom | British | 139588340001 | ||||||
| SLOAN, Alison May | Secretário | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
| SPEIRS, Ethel Victoria | Secretário | Altens AB12 3HT Aberdeen Peterseat Drive United Kingdom | 189601760001 | |||||||
| SUNDERMAN, Andrew | Secretário | 5635 Sage Manor Drive Houston Tx FOREIGN Harris 77084 Usa | Us Citizen | 63043210001 | ||||||
| ALTHOFF, David Eugene | Diretor | 5200 Blackhawk Drive Plano Texas 75093 Usa | Usa | 24686140001 | ||||||
| ARMBRUST, Charles Andrew | Diretor | 13111 Northwest Freeway 200 Houston Harris Texas 77040 FOREIGN Usa | American | 48304470001 | ||||||
| BLANFORD, Geoffrey Guy Trenchard | Diretor | High Ridge 12 Oak Drive Highworth SN6 7BP Swindon Wiltshire | British | 26924150001 | ||||||
| BOWLCOTT, Robert John | Diretor | Broadfield Court Barn Bishops Frome WR6 5BP Worcester Worcestershire | Gbr | British | 122447600001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Diretor | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| CONLEY, Thomas | Diretor | 914 Tate Trail San Marcos Texas 78666 United States | Usa | U S A | 133819400001 | |||||
| CRUMPLER, David Clark | Diretor | 2511 Silver Falls 77339 Kingswood Texas Usa | American | 34583000001 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Diretor | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||
| GREENVILLE, Sam | Diretor | 10703 Whisper Willow The Woodalnds Texas 77251-1489 FOREIGN Usa Usa | American | 44625240001 | ||||||
| HAVERTY, Michael Thomas | Diretor | Badentoy Avenue, Badentoy Park Portlethen AB12 4YB Aberdeen Distributionnow Scotland | Scotland | British | 188460720001 | |||||
| HENDRY, Eric George | Diretor | School Road AB1 0WB Newmachar 19 Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139588340001 | |||||
| HOLLINGSWORTH, George | Diretor | 43 Trafalgar Road WN1 2BB Wigan Lancashire | British | 24686150001 | ||||||
| HOPWOOD, Thomas James | Diretor | 1908 Augusta 21 Houston Texas Harris 77057 Usa | American | 34582930002 | ||||||
| JENNINGS, Craig | Diretor | 9007 Oakwind Ct Dallas Tx 75243 FOREIGN Usa Usa | American | 44625200001 | ||||||
| JONES, Stephen Graham Fairbrass | Diretor | Hedgehogs 8 Chase Close Coleshill HP7 0LX Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 12150560001 | |||||
| KOCHALSKI, Michael Peter | Diretor | Craigmyle Road Torphins AB31 4HN Aberdeenshire Charamillon United Kingdom | Scotland | British | 131958660001 | |||||
| MAHAN, Ryan Thomas | Diretor | Badentoy Avenue, Badentoy Park Portlethen AB12 4YB Aberdeen Distributionnow Scotland | Scotland | Usa | 188461420001 | |||||
| MC WHIRTER, Dow Ray | Diretor | 10003 Cedar Creek FOREIGN Houstow Texas Usa | Usa | 24686180001 | ||||||
| MCLEAN, Steven | Diretor | Altens AB12 3HT Aberdeen Peterseat Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 241180230001 | |||||
| MULKEY, Allison Lee | Diretor | 2206 Mediterranean Avenue 76011 Arlington Texas Usa | American | 38527820001 | ||||||
| NAFZIGER, Roger | Diretor | 8602 Haven Woods Way Tomball Tx FOREIGN Harris Usa 77385 | Us Citizen | 63043130001 | ||||||
| NAPIER, David Wyness | Diretor | Newburgh Circle Bridge Of Don AB22 8XA Aberdeen 79 Scotland | Scotland | British | 147413520001 | |||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Diretor | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| PEARCY, Willis Bedford | Diretor | 1503 Bodart FOREIGN Houston Texas 77090 Usa | Usa | 24686170001 | ||||||
| RAY, Richard, Vice President And Chief Financial Officer | Diretor | 1520 Preston Road 323 Plano Collin County Texas 75093 Usa | Usa | 33208080002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CONEMSCO LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now Inc | 11/02/2018 | North Elridge Parkway 77041 Houston 7402 Texas United States | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para CONEMSCO LIMITED?
| Notificado em | Cessado em | Declaração |
|---|---|---|
| 11/02/2017 | 11/02/2018 | A empresa ainda não concluiu as medidas razoáveis para determinar se existe alguma pessoa que seja uma pessoa registável ou uma entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
CONEMSCO LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of intercompany promissory note | Criado em 10/12/1997 Entregue em 23/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company or the borrower or all other obligors to the chargee (the terms grantor, borrower and obligor are used herein as defined in the credit agreement (defined below)) under the assignment and under the second amended and restated credit agreement dated as of may 17, 1996 (as amended and as may be further amended or otherwise modified from time to time, the "credit agreement") made among ceco holdings, inc., The banks (as therein defined) and the chargee or under any other agreement referred to in the credit agreement as a "note" or "loan document", whether for principal interest fees costs charges expenses or otherwise incurred by any secured party (as defined in the assignment) in connection with the protection preservation or enforcement of rights and benefits thereunder or under the assignment | |
Breve descrição All the rights title interest and benefit in and to the intercompany promissory note dated 10/12/97 issued to the assignor as payee by continental emsco company as maker as the same may be renewed amended.... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Floating charge debenture | Criado em 10/12/1997 Entregue em 23/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company or the borrower or all other obligors to the chargee (the terms grantor, borrower and obligor are used herein as defined in the credit agreement (defined below)) under the debenture and under the second amended and restated credit agreement dated as of may 17, 1996 (as amended and as may be further amended or otherwise modified from time to time, the "credit agreement") made among ceco holdings, inc., The banks (as therein defined) and the chargee or under any other agreement referred to in the credit agreement as a "note" or "loan document", whether for principal interest fees costs charges expenses or otherwise incurred by any secured party (as defined in the debenture) in connection with the protection preservation or enforcement of rights and benefits thereunder or under the debenture | |
Breve descrição First floating charge over all of the collateral defined in the debenture as all exisitng and hereafter acquired inventory receivables records collateral account and proceeds all as defined in the debenture. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0