CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 01088889 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 30/06/2024 |
Próximas contas vencem em | 31/03/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 30/06/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Última declaração de confirmação elaborada até | 29/03/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 12/04/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 29/03/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Término da nomeação de Howard William Nicholson como diretor em 31/10/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 29/03/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 páginas | AD03 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP United Kingdom para Mcbride Plc Arbeta 11 Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 páginas | AD02 | ||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 páginas | AD03 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 29/03/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2022 | 4 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2021 | 4 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2020 | 4 páginas | AA | ||
Nomeação de Mark William Strickland como diretor em 07/06/2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Huan George Quayle como secretário em 31/03/2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2019 | 4 páginas | AA | ||
Término da nomeação de David Thomas Rattigan como diretor em 31/01/2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Howard William Nicholson como diretor em 31/01/2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2018 | 4 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 30/09/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 páginas | AD03 | ||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para Mcbride Plc Central Park Northampton Road Manchester M40 5BP | 1 páginas | AD02 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2017 | 4 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Huan George Quayle como secretário em 15/01/2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Quem são os diretores de CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Christopher Ian Charles | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 194353920001 | ||||
STRICKLAND, Mark William | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Director | 284037180001 | ||||
BARNET, Carole Ann | Secretário | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | British | 687900001 | ||||||
QUAYLE, Huan George | Secretário | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | 242190550001 | |||||||
BARNET, Carole Ann | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester Robert Mcbride Ltd | England | British | Company Secretary | 687900001 | ||||
BARRISKELL, Simon Francis | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Accountant | 159313890002 | ||||
HANDLEY, Michael | Diretor | 5 Meryton House Imperial Park Imperial Road SL4 3TW Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 11908890002 | ||||
KENDRICK, John Alderson | Diretor | Greenlands Sand Lane Nether Alderley SK10 4TS Macclesfield Cheshire | England | British | Chartered Accountant | 800840001 | ||||
LINDSAY, Andrew | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Accountant | 78337450002 | ||||
MCINTYRE, Colin Stuart | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | England | British | Managing Director | 196049590001 | ||||
MONKS, Terence John | Diretor | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 80344460001 | |||||
MURFIN, Andrew James | Diretor | 48 Hawthorne Way Shelley HD8 8JX Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 68921430001 | ||||
NICHOLSON, Howard William | Diretor | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester | United Kingdom | British | Finance Director | 158054790002 | ||||
RATTIGAN, David Thomas | Diretor | Middleton M24 4DP Manchester Middleton Way United Kingdom | England | British | Accountant | 267716900001 | ||||
SEAMAN, Timothy Nicholas Motum | Diretor | Durran Haslingden Road BB4 6QX Rawtenstall Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 126365880001 | ||||
SEAMAN, Timothy Nicholas Motum | Diretor | Durran Haslingden Road BB4 6QX Rawtenstall Lancashire | England | British | Chartered Accountant | 126365880001 | ||||
SOWERBUTTS, Warwick Anthony | Diretor | 32 Woodlands Park Whalley BB6 9UG Blackburn Lancashire | British | Director | 50200400002 | |||||
WIDDUP, John Woodley | Diretor | Beeches Legh Road Prestbury SK10 4HX Macclesfield Cheshire | British | Director | 1260350001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mcbride Ltd | 06/04/2016 | Middleton Way Middleton M24 4DP Manchester Robert Mcbride England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
CAMILLE SIMON HOLDINGS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Criado em 28/05/1993 Entregue em 14/06/1993 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility documents and/or the security documents (as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 22/10/1985 Entregue em 30/10/1985 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land at rear of the company's barrow d factory & part of sowerby hall farm barrow-in-furness cumbria. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 21/03/1984 Entregue em 29/03/1984 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição (See doc M34). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 10/10/1983 Entregue em 14/10/1983 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £200.000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição Land and factory buildings at park road, barrow-in-furness, cumbria as comprised in a transfer dated 10TH october 1983. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 22/05/1981 Entregue em 12/06/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H 189 london road stainls surrey title no sy 418468. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 13/05/1981 Entregue em 22/05/1981 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição F/H land on the northerly side of and fronting to cooper lane, bardsea, nr ulverston, cumbria (now known as unit C. cooper lane). | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0