MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMOTHERCARE TOYS 3 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 01103663
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    EARLY LEARNING LIMITED23/03/197323/03/1973

    Quais são as últimas contas de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até27/03/2021

    Quais são as últimas submissões para MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    18 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 24/10/2023

    17 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de Westside 1 London Road Hemel Hempstead HP3 9TD United Kingdom para Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU em 07/11/2022

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 25/10/2022

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Estado do capital em 25/04/2022

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 6

    2 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 011036630007

    1 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 011036630008

    1 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 011036630009

    1 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 011036630010

    1 páginasMR05

    Satisfação total da garantia 6

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 011036630007

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 011036630008

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 011036630009

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 011036630010

    1 páginasMR04

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/03/2021

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/06/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MEDINI, Lynne Samatha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secretário
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    British167184730001
    COOK, Andrew
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Diretor
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishAccountant266409860001
    MEDINI, Lynne Samantha
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Diretor
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    EnglandBritishChartered Secretary70989770003
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Secretário
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    British44142970001
    BRAMALL, Helen Mary
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Secretário
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary59695650001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Secretário
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Secretário
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    British116097830001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Secretário
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    MULHOLLAND, Eric
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    Secretário
    81 Auchingane
    EH10 7HU Edinburgh
    British984680001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Secretário
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    UsFinance Director97940820001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    Secretário
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    British134102250001
    J M SECRETARIES LIMITED
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    Secretário
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    61308040001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Diretor
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ANDERSON, Charles Adair
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    Diretor
    Ravensheugh
    TD7 5LS Selkirk
    United KingdomBritishChartered Accountant44142970001
    ASHBY, Timothy John
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Great BritainBritishGeneral Counsel162876770001
    ATWAL, Harminder Singh
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant167976490001
    BENNETT, James Douglas Scott
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    Diretor
    The Well House
    3 Easter Belmont Road
    EH12 6EX Edinburgh
    BritishCompany Director365550003
    BLACK, Robert
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    Diretor
    The Coach House 1 Templars Cramond
    EH4 6BY Edinburgh
    BritishCompany Director50558240001
    BOYDELL, Joanna
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118883430001
    CLARK, Darren Wayne
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant212137270001
    CRANKSHAW, Andrew Ernest
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    Diretor
    Lucerne Piece 51 Cricklade Road
    Highworth
    SN6 7RJ Swindon
    United KingdomBritishCompany Director28581470002
    DUNCAN, Robert Ian
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    Diretor
    Oakley Houser
    Oak Drive
    SN6 7BP Swindon
    Wiltshire
    BritishCompany Director59423840001
    ELLIS, Peter Malcolm
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    The Orchard
    Old Forge, Ewen
    GL7 6BU Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director55540630003
    FRANCE, Michael Bernard Anthony
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    Diretor
    Ford Cottage Sandpit Lane
    Bledlow
    HP27 9QL Princess Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director141561430001
    GRIFFITHS, David
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    Diretor
    17 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midlands
    BritishFinance Director78157950002
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishGroup Finance Director157815820001
    HOMER, Kirsty Rowena
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishHr Director235620910001
    JENKINSON, Dermot Julian
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    Diretor
    Mersington House
    Greenlaw
    TD10 6UL Duns
    Berwickshire
    ScotlandBritishCompany Director681840002
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Diretor
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    EnglandBritishFinance Director116097830001
    JUCKES, Daniel
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    Diretor
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant255996600001
    MACKAY, David James
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    Diretor
    4 East Harbour Road
    KY11 3EA Charlestown
    Fife
    ScotlandBritishCompany Director681850002
    MARTIN, Alan
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant188726960001
    NEEDHAM, Phillip Geoffrey
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    Dickens House Charlham Lane
    Down Ampney
    GL7 5RQ Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58920590001
    NOEL-PATON, Frederick Ranald, The Hon
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    Diretor
    Easter Dunbarnie
    Bridge Of Earn
    PH2 9ED Perth
    Perthshire
    BritishCompany Director21482560001
    RAINER, Michael James
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    Diretor
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    United KingdomBritishChartered Accounta14442650003

    Quem são as pessoas com controle significativo de MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    06/04/2016
    London Road
    HP3 9TD Hemel Hempstead
    Westside 1
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro00102194
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 17/05/2018
    Entregue em 23/05/2018
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transações
    • 23/05/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 06/12/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 17/05/2018
    Entregue em 23/05/2018
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transações
    • 23/05/2018Registro de uma garantia (MR01)
    • 20/05/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 05/05/2017
    Entregue em 12/05/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transações
    • 12/05/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 20/05/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 05/05/2017
    Entregue em 12/05/2017
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    N/A.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transações
    • 12/05/2017Registro de uma garantia (MR01)
    • 06/12/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Share mortgage
    Criado em 18/05/2012
    Entregue em 07/06/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares being 100 ordinary share of hk$1 each in the issued share capital of mgsl, constituting the entire issued share capital of mgsl, comprising of 1 ordinary share being held by the chargor and 99 ordinary shares being held by early learning centre limited.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 07/06/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 06/12/2021Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 11/04/2012
    Entregue em 26/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 26/04/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 20/05/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 06/12/2021Satisfação de uma garantia (MR04)
    Guarantee & debenture
    Criado em 11/08/2006
    Entregue em 30/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    87 high street bedford t/no BD103103 3 hounds hill centre blackpool t/no LA501867 31 lion yard cambridge t/no CB58716 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • D.C. Thomson & Company Limited
    Transações
    • 30/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Criado em 02/04/2004
    Entregue em 15/04/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    87 high street bedford t/n BD103103, 3 hounds hill centre t/n LA501867, 31 lionyard cambridge t/n CB58716 for details of further properties charged please refe. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    Transações
    • 15/04/2004Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/09/2001
    Entregue em 09/10/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any holder of payment in kind notes pursuant to the investment agreement of even date
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • 3I Investments PLC
    Transações
    • 09/10/2001Registro de uma garantia (395)
    • 10/04/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 28/09/2001
    Entregue em 05/10/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness liabilities and obligations which are as at 28 september 2001 or may at any time thereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever to the bank by any group company on any account whatsoever under the terms of the deed
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 05/10/2001Registro de uma garantia (395)
    • 11/05/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    MOTHERCARE TOYS 3 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    25/10/2022Início da liquidação
    17/05/2024Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0